32
Published by Ministry of Government Services © Queen’s Printer for Ontario, 2011 Publié par le Ministère des Services gouvernementaux © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2011 4387 Vol. 144-52 Toronto ISSN 00302937 Saturday, 24 December 2011 Le samedi 24 Decembre 2011 Proclamation ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi. PROCLAMATION PROCLAMATION CHILD AND FAMILY SERVICES AMENDMENT ACT (CHILD WELFARE REFORM), 1999 LOI DE 1999 MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE (RÉFORME DU BIEN-ÊTRE DE L'ENFANCE) We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 20, 2011 as the day on which subsection 2 (3) of the Child and Family Services Amendment Act (Child Welfare Reform), 1999, c. 2, comes into force. Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 20 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (réforme du bien-être de l'enfance), chap. 2. WITNESS: TÉMOIN: THE HONOURABLE DAVID C. ONLEY LIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO L’HONORABLE DAVID C. ONLEY LIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011. BY COMMAND PAR ORDRE HARINDER JEET SINGH TAKHAR Minister of Government Services HARINDER JEET SINGH TAKHAR (144-G606) ministre des Services gouvernementaux

Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

Published by Ministry of Government Services © Queen’s Printer for Ontario, 2011Publié par le Ministère des Services gouvernementaux © Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2011

4387

Vol. 144-52 Toronto ISSN 00302937Saturday, 24 December 2011 Le samedi 24 Decembre 2011

Proclamation

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

CHILD AND FAMILY SERVICES AMENDMENT ACT (CHILD WELFARE REFORM), 1999

LOI DE 1999 MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE (RÉFORME DU BIEN-ÊTRE DE L'ENFANCE)

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 20, 2011 as the day on which subsection 2 (3) of the Child and Family Services Amendment Act (Child Welfare Reform), 1999, c. 2, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 20 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille (réforme du bien-être de l'enfance), chap. 2.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G606) ministre des Services gouvernementaux

Page 2: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4388 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

GOVERNMENT PROCESS SIMPLIFICATION ACT (MINISTRY OF HEALTH), 1997

LOI DE 1997 VISANT À SIMPLIFIER LES PROCESSUS GOUVERNEMENTAUX AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 31, 2011 as the day on which section 6 of the Government Process Simplification Act (Ministry of Health), 1997, c. 15, which amends the Homemakers and Nurses Services Act, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 31 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur l’article 6 de la Loi de 1997 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère de la Santé, chap. 15, qui modifie la Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G607) ministre des Services gouvernementaux

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

LONG-TERM CARE ACT, 1994 LOI DE 1994 SUR LES SOINS DE LONGUE DURÉE

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 31, 2011 as the day on which the following provisions of the Long-Term Care Act, 1994, c. 26, come into force:

1. Section 71, which amends the Health Protection and Promotion Act.

2. Section 72, which amends the Homemakers and Nurses Services Act.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 31 décembre 2011 comme le jour où entrent en vigueur les dispositions suivantes de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, chap. 26 :

1. L’article71,quimodifielaLoi sur la protection et la promotion de la santé.

2. L’article 72, quimodifie laLoi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G608) ministre des Services gouvernementaux

Page 3: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4389

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

ONTARIO COLLEGE OF TRADES AND APPRENTICESHIP ACT, 2009

LOI DE 2009 SUR L'ORDRE DES MÉTIERS DE L'ONTARIO ET L'APPRENTISSAGE

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name January 1, 2012 as the day on which sections 10 and 11, subsections 21 (1) to (4) and sections 60 and 61 of the Ontario College of Trades and Apprenticeship Act, 2009, c. 22, come into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 1er janvier 2012 comme le jour où entrent en vigueur les articles 10 et 11, les paragraphes 21 (1) à (4) et les articles 60 et 61 de la Loi de 2009 sur l'Ordre des Ímétiers de l'Ontario et l'apprentissage, chap. 22.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G609) ministre des Services gouvernementaux

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

RED TAPE REDUCTION ACT, 1999 LOI DE 1999 VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 30, 2011 as the day on which sections 30, 31 and 32 of Schedule F to the Red Tape Reduction Act, 1999, c. 12, which amend the Marriage Act, come into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 30 décembre 2011 comme le jour où entrent en vigueur les articles 30, 31 et 32 de l’annexe F de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives, chap.12,quimodifientlaLoi sur le mariage.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G610) ministre des Services gouvernementaux

Page 4: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4390 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

RED TAPE REDUCTION ACT, 1999 LOI DE 1999 VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 31, 2011 as the day on which subsection 4 (4) of Schedule B to the Red Tape Reduction Act, 1999, c. 12, which amends the Courts of Justice Act, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 31 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 4 (4) de l’annexe B de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives, chap. 12, quimodifielaLoi sur les tribunaux judiciaires.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G611) ministre des Services gouvernementaux

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

RED TAPE REDUCTION ACT, 2000 LOI DE 2000 VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 30, 2011 as the day on which subsection 5 (2) of Schedule B to the Red Tape Reduction Act, 2000, c. 26, which amends the Change of Name Act, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 30 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 5 (2) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, chap. 26, quimodifielaLoi sur le changement de nom.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G612) ministre des Services gouvernementaux

Page 5: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4391

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

RED TAPE REDUCTION ACT, 1999 LOI DE 1999 VISANT À RÉDUIRE LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 31, 2011 as the day on which Schedule D to the Red Tape Reduction Act, 1999, c. 12, being the Settlement of International Investment Disputes Act, 1999, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 31 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur l’annexe D de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives, chap. 12, qui constitue la Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G613) ministre des Services gouvernementaux

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

SECURING PENSION BENEFITS NOW AND FOR THE FUTURE ACT, 2010

LOI DE 2010 SUR LA PÉRENNITÉ DES PRESTATIONS DE RETRAITE

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name January 1, 2012 as the day on which subsection 38 (1) of the Securing Pension Benefits Now and for the Future Act, 2010, c. 24, which amends the Pension Benefits Act, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 1er janvier 2012 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 38 (1) de la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite,chap.24,quimodifielaLoi sur les régimes de retraite.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G614) ministre des Services gouvernementaux

Page 6: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4392 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

STATUTE LAW AMENDMENT ACT (GOVERNMENT MANAGEMENT AND SERVICES), 1994

LOI DE 1994 MODIFIANT DES LOIS EN CE QUI A TRAIT AUX PRATIQUES DE GESTION ET AUX SERVICES DU GOUVERNEMENT

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name December 30, 2011 as the day on which subsection 79 (2) of the Statute Law Amendment Act (Government Management and Services), 1994, c. 27, which amends the Corporations Information Act, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 30 décembre 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 79 (2) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement, chap. 27, qui modifie la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G615) ministre des Services gouvernementaux

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom, Canada and Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

PROCLAMATION PROCLAMATION

WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE AMENDMENT ACT, 2008 LOI DE 2008 MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

We, by and with the advice of the Executive Council of Ontario, name January 1, 2012 as the day on which section 9 of the Workplace Safety and Insurance Amendment Act, 2008, c. 20, comes into force.

Sur l’avis du Conseil exécutif de l’Ontario, nous désignons le 1er janvier 2012 comme le jour où entre en vigueur l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, chap. 20.

WITNESS: TÉMOIN:

THE HONOURABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT GOVERNOR OF OUR PROVINCE OF ONTARIO

L’HONORABLEDAVID C. ONLEYLIEUTENANT-GOUVERNEUR DE NOTRE PROVINCE DE L'ONTARIO

GIVEN at Toronto, Ontario, on December 14, 2011. FAIT à Toronto (Ontario) le 14 décembre 2011.

BY COMMAND PAR ORDRE

Harinder Jeet SingH takHarMinister of Government Services

Harinder Jeet SingH takHar(144-G616) ministre des Services gouvernementaux

Page 7: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4393

Ontario Highway Transport Board

Periodically, temporary applications are filedwith theBoard.Details ofthese applications can be made available at anytime to any interested parties by calling (416) 326-6732.

The following are applications for extra-provincial and public vehicle operating licenses filed under the Motor Vehicle Transport Act, 1987,and the Public Vehicles Act. All information pertaining to the applicant i.e.businessplan,supportingevidence,etc.isonfileattheBoardandisavailable upon request.

Any interested person who has an economic interest in the outcome of theseapplicationsmayserveandfileanobjectionwithin29daysofthispublication. The objector shall:

1. complete a Notice of Objection Form,

2. serve the applicant with the objection,

3. fileacopyoftheobjectionandprovideproofofserviceoftheobjectionon the applicant with the Board,

4. pay the appropriate fee.

Serving andfiling an objectionmaybe effected by handdelivery,mail,courierorfacsimile.Servingmeansthedatereceivedbyapartyandfilingmeans the date received by the Board.

LES LIBELLÉS DÉS DEMANDES PUBLIÉES CI-DESSOUS SONT AUSSI DISPONIBLES EN FRANÇAIS SUR DEMANDE.

Pour obtenir de l’information en français, veuillez communiquer avec la Commission des transports routiers au 416-326-6732.

D & F Travel, Inc. 47449338 Central Ave., Suite 320, Dunkirk, NY 14048, USA.Applies for an extra-provincial operating licence as follows:For the transportation of passengers on a chartered trip from points in the United States of America as authorized by the relevant jurisdiction from the Ontario/U.S.A., Ontario/Québec and Ontario/Manitoba border crossings:1. to points in Ontario; and2. in transit through Ontario to the Ontario/Manitoba, Ontario/Québec,

and Ontario/U.S.A. border crossings for furtherance;and for the return of the same passengers on the same chartered trip to point of origin.PROVIDED THAT there be no pick-up or discharge of passengers except at point of origin.3. to points in Ontario on a one-way chartered trip without pick-up of

passengers in Ontario.

XtremePartyBus and Limousine Services Incorporated 474473462 Legault Rd., Hammond, ON K0A 2A0Applies for the approval of transfer of public vehicle operating licence PV-5486 now in the name of 4260252 Canada Inc., 2020 Jasmine Cres., Suite 718, Gloucester, ON K1J 8K5.

Felix d’mello(144-G617) Board Secretary/Secrétaire de la Commission

Government Notices Respecting Corporations Avis du gouvernements relatifs aux compagnies

Notice of Default in Complying with the Corporations Tax Act

Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés

The Director has been notified by the Minister of Finance that thefollowing corporations are in default in complying with the Corporations Tax Act.

NOTICE IS HEREBY GIVEN under subsection 241(1) of the Business Corporations Act, that unless the corporations listed hereunder comply with the requirements of the Corporations Tax Act within 90 days of this notice, orders will be made dissolving the defaulting corporations. All enquiries concerning this notice are to be directed to Ministry of Finance, Corporations Tax, 33 King Street West, Oshawa, Ontario L1H 8H6.

Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

2011-12-24AEROTEST CORP. 001663393

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

AMBER & YORK HOLDINGS INC. 001209847B.I.L.D.O.N. CONSTRUCTION (445) INC. 002088451BALDWIN MANTLE & WOODWORKING LTD. 001117405BANEL HOLDINGS LIMITED 000228912BONITO ENTERPRISES INC. 001621957CASTLEMORE MCVEAN HOLDINGS LTD. 001453217CENTRAL ONTARIO CRANE RENTALS INC. 001430957CHINA GARDEN 88 (BRADFORD) INC. 001051089CHINESE CASUAL DINER INC. 001302303CHOICE CAR & TRUCK RENTALS LTD. 001606558COFFEE PERKS & DONUTS LTD. 001455609COMPUTERIZED CUTTERS LTD. 000402204COMPUTERS @ THE MANOR INC. 001205928DELAWARE FOREST PRODUCTS INC. 001664051DEXIOR FINANCIAL (ONTARIO) INC. 001487933DHUNNA FREIGHT SYSTEM INC. 001546001DILNAZ HOLDINGS INC. 001249263DURHAM LIQUIDATION INC. 001634984DUVAL & ASSOCIATES LTD. 002067716ERISH COMPUTER AND COMMUNICATION SERVICES INC. 002086058EXPLORER INTERNATIONAL TRADE INC. 001600741FITZGERALD INSURANCE BROKERAGE LIMITED 000434292GASMAC INC. 000544145GCL MARKETING INC. 000973548GEORGE HAYES TECHNICAL SERVICES LTD. 000472706GIBNEY INVESTMENTS INC. 001073257GRIDPOINT TECHNOLOGY INC. 002066403HEBERT DESIGN & CONSTRUCTION LIMITED 001414425HEDEFX CORPORATION 001461026IMESON TRUCKING LTD. 001109092

Page 8: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4394 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

INTRACAP REAL ESTATE INC. 002087831JACLAR LTD. 001296967JAMESONS TRANSPORT INC. 002042740JOHN BERGMAN AND SONS NURSERIES LTD. 000362253KEOUGHS INC. 002106298KROKUS BAKERY INC. 001036736LINDEN HOMES LIMITED 001229140LOYAL TRUCK LINES LTD. 001154976M & B GENERAL WELDING & MACHINE SHOP LTD. 000739512MAITRE BERNHARD LIMITED 000824925MAJORICH TRADING & CO. LTD. 001575515MATTHEWS ASSET MANAGEMENT INC. 001139741MEGAFORM CONSTRUCTION ONTARIO LTD. 001633887MJP ENTERPRISES LTD. 000577878MORTGAGE MIRACLE INC. 002082939NEW PASUPATHY VILAS INC. 002098555OMEGA MANTELS LTD. 001393396PARTH CONVENIENCE INC. 001368803PATRICK REID CONSULTING LTD. 001292088PEPPERS LIMITED 001453446PN FREIGHT LTD. 002162247PREMIUM PORK (LONDON LINE) INC. 001433558Q2 CONTROL INC. 002066972RA-GO-FRE INVESTMENTS INC. 001671912RAILSIDE MANAGEMENT INC. 001313174REIGN FLOORING LTD. 002015899ROSEMARY TRANSPORT LTD. 001701831ROYALTY WEAR INC. 001012430SE CONTRACTING ALUMINUM SERVICES INC. 001544030SHELMAR BUSINESS PLANNING & CONSULTING INC. 000916995STRESS FREE ACCOUNTING INC. 001550870TARA TOBACCO FARMS INC. 001370870TECHNOLOGY MADE EASY INCORPORATED 001420332THE CSD GROUP LIMITED 000896928THE GEM GROUP LIMITED 001413849THE RELEASE CORPORATION 001492247TORONTOSEEKER LTD. 001587919TRADEMARK PROPERTY DEVELOPMENT INC. 001697052TRILLION DEVELOPMENT INC. 002091555TRINITY WOOD CAPITAL CORPORATION 001105049TWIN JO PROPERTIES LTD. 001105920VALUE RENOVATION AND WOODCRAFT INC. 001632676VR PROFESSIONALS INC. 001352577WHITE STONE PLASTERING & STUCCO LTD. 001487672WILSON SHEET METAL INC. 000843593YSMR PHOTOGRAPHY INC. 0013396581014153 ONTARIO LIMITED 0010141531061033 ONTARIO LTD. 0010610331061079 ONTARIO INC. 0010610791069673 ONTARIO LIMITED 0010696731126397 ONTARIO INC. 0011263971221950 ONTARIO INC. 0012219501261001 ONTARIO INC. 0012610011284559 ONTARIO INC. 0012845591300947 ONTARIO INC. 0013009471325224 ONTARIO INC. 0013252241331439 ONTARIO INC. 0013314391338437 ONTARIO INC. 0013384371346956 ONTARIO INC. 0013469561355188 ONTARIO LTD. 0013551881406366 ONTARIO LTD. 0014063661414694 ONTARIO INC. 0014146941444683 ONTARIO LIMITED 0014446831444758 ONTARIO INC. 0014447581447495 ONTARIO LTD. 0014474951457654 ONTARIO INC. 001457654

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

1463652 ONTARIO INC. 0014636521464173 ONTARIO INC. 0014641731494036 ONTARIO INC. 0014940361533380 ONTARIO INC. 0015333801554435 ONTARIO INC. 0015544351606191 ONTARIO INC. 0016061911636589 ONTARIO INC. 0016365891670049 ONTARIO LIMITED 0016700491673721 ONTARIO INC. 0016737211709532 ONTARIO INC. 0017095321728272 ONTARIO INC. 0017282722004121 ONTARIO INC. 0020041212021381 ONTARIO INC. 0020213812027790 ONTARIO INC. 0020277902031360 ONTARIO INC. 0020313602043112 ONTARIO INC. 0020431122048047 ONTARIO INC. 002048047356540 ONTARIO LIMITED 000356540932385 ONTARIO LIMITED 000932385934653 ONTARIO LTD. 000934653941057 ONTARIO INC. 000941057988524 ONTARIO INC. 000988524989280 ONTARIO INC. 000989280

katHerine m. murrayDirector, Ministry of Government ServicesDirectrice, Ministère des Services

(144-G618) gouvernementaux

Cancellation of Certificate of Incorporation

(Corporations Tax Act Defaulters) Annulation de certificat de constitution

(Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, under subsection 241(4) of the Business Corporations Act, the Certificate of Incorporation of thecorporations named hereunder have been cancelled by an Order for default in complying with the provisions of the Corporations Tax Act, and the said corporations have been dissolved on that date.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat deconstitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

2011-11-28A & NA HOLDING INC. 001012505ADELANJA CONSULTING INC. 001444757ADVANCED DESIGN INC. 001633407ALFA DIN INC. 000382024ALPHABYTES COMPUTER CORPORATION 000541304APL ENVIRONMENTAL INC. 001456125ARM-STRONG FENCE & DECK LTD. 001030273AUGIE’S ELECTRIC INC. 000890420BKP SYSTEMS INC. 001052037BLACK SHIELD MARKETING CONSULTANTS INC. 000976085

Page 9: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4395

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

BLUE EAGLE NORTH CONSTRUCTION COMPANY INC 000850733BLUEGREEN LIMITED 000605089BOOK IT MANAGEMENT INC. 001434472CANADA-POLAND BUSINESS BRIDGES CORPORATION 001446313CANADIAN MINING INNOVATIONS MAGAZINE INC. 001167809CASTANET CORP. 001119945CELEBRATIONS IN ELEGANCE INC. 001233815CHROMOS NETWORK LTD. 001045637CLARKSON MASONRY LTD. 000935252COMFORT UPHOLSTERY LTD. 000578053CVR INFORMATION GROUP INC. 001073873CYHAN CONCEPTS INC. 001050441DANNICK DECORATING INC. 000844601DDA COMPUTER SYSTEMS LIMITED 000852122DEVELIN OFFICE DESIGNS INC. 002082382DIGITRON HOLDINGS INC. 001119924DIMICAN INC. 002046047DOVECO INC. 001529434DREAMWORLD TRAVEL & VACATIONS INC. 001509561EMBEHAN PROPERTY MANAGEMENT, INC. 001500019ERIC MARKOVIC CONSULTING INC. 001328231FIREWORKS FIREPLACES DESIGN INC. 001633571FITNESS AT HOME INC. 001464668G. HUBER TRUCKING INC. 001452009GRAHAM FORMS INC. 001544006HARRIS PRECOM INC 000969101HELIOTRONIC ENERGY SYSTEMS INC. 000419348IMRAN DYNAMIC INVESTMENTS INC. 001419278JEDOF DEVELOPMENTS LIMITED 000637789JIAYU INTERNATIONAL INC. 001121041JUESBERY CORPORATE SERVICES INC. 001686428KEA PRECISION PRINTING LTD. 001446331LAURIE LYNN HOSIERY LTD. 000517493LES VISAGE SCIENTIFIC SKIN CARE CLINIC INC. 001133117LYSTER FINANCIAL SERVICES INC. 001190760MAJESTIC BUILDERS INC. 001061109MARKSALL CORP. 002074813MELROSE COLLECTION LTD. 001365863METADYNE RESEARCH CORPORATION 001482405MULTI TRADES ENTERPRISE INC. 000861712PERN CONSTRUCTION INC. 000937081PET PARADISE INC. 002115007POLVIAN CONSTRUCTION LIMITED 000339309R. J. PARTINGTON & ASSOCIATES INC. 001198254R.S.SUPER DEAL INC. 002074248RICHARD SCHINKEL CONSULTING INC. 001067200RODERIK TRANSPORT LTD. 001396155ROMLEE LAND DEVELOPMENT INC. 000880501RT LEASING MANAGEMENT LTD. 001668790SHERWOOD III LIMITED 001078097SINGHBAY.COM INC. 002057559SISCIA TRANSPORTATION SOLUTION LTD. 002055698SPORTSVUE INC. 001068901SUMMIT GRANITE & MARBLE INC. 001749061SUPER HALF HOUR PHOTO INC. 002017876TEMPO DESIGN ALTERNATIVES INC. 000577177THE INTELLIGENT COMPUTER PEOPLE INC. 000903588THE ROYALTON RETIREMENT RESIDENCE INC. 002089082THE SIRIUS PET FOOD COMPANY INC. 001081192TTI TRAVEL SHOP LIMITED 000105096VF AUTOBAHN AUTO SALON & ACCESSARIES INC. 001052317VILA FRANCA FORMING LTD. 001607534WEST CAMP DRYWALL INC. 0012023701008481 ONTARIO LIMITED 001008481

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

1020132 ONTARIO INC. 0010201321021189 ONTARIO LIMITED 0010211891052909 ONTARIO LIMITED 0010529091095085 ONTARIO INC. 0010950851103924 ONTARIO LIMITED 0011039241106541 ONTARIO LTD. 0011065411128753 ONTARIO INC. 0011287531194791 ONTARIO LIMITED 0011947911240134 ONTARIO INC. 0012401341360776 ONTARIO LTD 0013607761382567 ONTARIO LIMITED 0013825671410176 ONTARIO INC. 0014101761424419 ONTARIO INC. 0014244191477034 ONTARIO INC. 0014770341532100 ONTARIO INC. 0015321001604958 ONTARIO INC. 0016049581674906 ONTARIO LIMITED 0016749062012877 ONTARIO INC. 0020128772017720 ONTARIO INC. 0020177202021999 ONTARIO INC. 0020219992033327 ONTARIO INC. 0020333272036360 ONTARIO INC. 0020363602053588 ONTARIO INC. 0020535882056292 ONTARIO LTD. 0020562922063758 ONTARIO INC. 002063758558896 ONTARIO LIMITED 000558896595836 ONTARIO LIMITED 000595836621464 ONTARIO LTD. 000621464904657 ONTARIO LIMITED 000904657905913 ONTARIO INC. 000905913941669 ONTARIO INC. 000941669972265 ONTARIO LIMITED 000972265

katHerine m. murrayDirector, Ministry of Government ServicesDirectrice, Ministère des Services

(144-G619) gouvernementaux

Certificate of Dissolution Certificat de dissolution

NOTICEISHEREBYGIVENthatacertificateofdissolutionunder theBusiness Corporations Act, has been endorsed. The effective date of dissolution precedes the corporation listings.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions,uncertificatdedissolutionaétéinscritpourles compagnies suivantes : la date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

2011-10-27806000 ONTARIO INC. 0008060002011-11-02ALEX PETROVIC DRYWALL CONTRACTOR LIMITED 000291167DAEBURN CONSTRUCTION LIMITED 000699433FSS MANAGEMENT INC. 002098384HOLD THE FOCUS CORP. 002285705JIM & RON BALL LTD. 000336558LITTLE LULU’S CAFE INC. 001143928

Page 10: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4396 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

NEW HEIGHTS SPORTS INC. 001462918O’MALLEY & ASSOCIATES CONSULTING SERVICES LTD. 001011187P & J MEDICAL CONSULTING INC. 001687966RUSS HODGES TRUCKING INC. 0011420251576575 ONTARIO INC. 0015765752259806 ONTARIO INC. 002259806483812 ONTARIO LIMITED 0004838122011-11-03A & A VALET SERVICES INC. 001028440A G VLAHAKIS, INC. 002095318AJOUR CORPORATION 002127346ARTICULATED PICTURES INC. 002163292BACK WORLD INC. 001189565BRENCADON CORPORATION 000791480CAVAN B. ACHESON PROFESSIONAL CORPORATION 002051320DANIEL INVESTMENTS & DEVELOPMENTS COMPANY LIMITED 002047693DAVID MCCORMACK INC. 002028198DEMAND PLUMBING & MECHANICAL INC. 001648462E S BUILDERS INC. 001727677FIELD ELECTRICAL CORPORATION 002257474FIRST CHOICE WINDOWS AND DOORS INC. 002008485INSIGHT ELECTRONICS CORPORATION 002068560J & S PAPADAKIS LTD. 000407246KARL OTT CONSTRUCTION LTD. 000353947KWAN & ASSOCIATES FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC. 002110686MAINSTREAMS PUBLICATIONS INC. 001736704MARLEE VILLAGE INC. 002016803MFS PRODUCTIONS INC. 001461261NASEER BROTHERS INCORPORATED 000901958NORTHERN VOICE & DATA TRAINING SERVICES INC. 001582773P.I.M.P. ENTERPRISES INC. 002043516PAUL’S HOLDINGS INC. 001653627PLACE NOTRE DAME INC. 000772280ROSETTA CONSULTING INC. 001292107STEPHEN J. ARNOLD RESEARCH LIMITED 000476624STEVEN LAFLAMME ENTERTAINMENT INC. 002152147SUNCROFT COMPUTER INC. 001167824SUPREME HUMAN RIGHTS, LABOUR RELATIONS & TRAINING LTD. 0017277831264189 ONTARIO LTD 0012641891545341 ONTARIO INC. 0015453411641371 ONTARIO INC. 0016413711764083 ONTARIO LIMITED 0017640832131190 ONTARIO INC. 0021311902147593 ONTARIO INC. 0021475932183883 ONTARIO INC. 002183883338820 ONTARIO LTD. 0003388202011-11-04ADLINGTON FARMS LIMITED 000366288AFFINITY REAL ESTATE SERVICES INC. 001484824AL AZHAR MONEY EXCHANGE INC. 002168658AMAIZE INC. 001137310ASEEM INVESTMENTS INC. 001793176DORIAN’S FASHION REFLECTIONS LTD. 000921971DREAMS COME TRUE PRODUCTIONS INC. 001251943ELOBSTER INCORPORATED 002103479FUNCTION13 INC. 002183588GEORGE R. SMITH ENTERPRISES INC. 000669456LOWELL BROWNING & ASSOCIATES LTD. 000635861MASTON CONSULTING INC. 001133163PRIME DESTINATIONS INC. 001748360SEABREEZE SERVICES INC. 001302787

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

SENTEC SECURITY SERVICES INC. 001235389SIMPLYMONOGRAMMED.COM LTD. 002218701TWOJOURS INC. 0011351651254805 ONTARIO INC. 0012548051470788 ONTARIO INC. 0014707881615400 ONTARIO INC. 0016154001772598 ONTARIO INC. 0017725982115409 ONTARIO INC. 002115409619290 ONTARIO LIMITED 000619290707880 ONTARIO LTD. 000707880766553 ONTARIO INC. 000766553928832 ONTARIO INC. 000928832933111 ONTARIO INC. 0009331112011-11-05KEY OPTIMEDIA INC. 0021562012011-11-07A. MACRI LANGUAGE SERVICES LTD. 000731486ABSOLUTE INDUSTRIAL MACHINE REPAIR INC. 001786644C&J DELITOPIA INC. 001743208CLARFIELD CONSULTING INC. 002001546D G V SOLUTIONS INC. 001315230DEBCO BUILDING CENTRE LTD. 001015139EQUAL FUND MANAGEMENT LTD. 002107183INNOVATIVE DYNAMIX HEALTHCARE INC. 002048142JCHU CONSULTING INC. 000940419K.W.L. SALES AND CONSULTING INC. 002178246LE FIRME TOO INC. 002009394OLLAG ASSOCIATE ENTERPRISES INC. 001673718OLO CONSULTING INC. 001325541OTTAWA FLAGS & POLES INC. 001850515RIPPER’S BAR & GRILL INC. 001605892ROSSIG ENTERPRISES LTD. 001484092S. TIFFIN REALTY INC. 000705052WILDERNESS CITY PHARMACY LTD. 0017962631019557 ONTARIO INC. 0010195571141920 ONTARIO LIMITED 0011419201314435 ONTARIO INC. 0013144351369829 ONTARIO INC. 0013698291425415 ONTARIO INC. 0014254151531561 ONTARIO INC. 0015315612 BEES FAMILY MART LTD. 0010171912020608 ONTARIO LIMITED 0020206082105527 ONTARIO INC. 0021055272172574 ONTARIO INC. 0021725742207152 ONTARIO LTD. 002207152589258 ONTARIO INC. 000589258748072 ONTARIO LIMITED 000748072824624 ONTARIO INC. 000824624993436 ONTARIO LIMITED 0009934362011-11-08ALMOND DELIGHTS LTD. 001319413DANAMAE SALES INC. 001311878DELTHA HEALTHCARE INC. 002180466FLIPSIDE FORWARDING INC. 002059534FOUR CHAMBERS DIAGNOSTICS INC. 001512124GADCO TOOL & DIE MFG. LTD. 000586452GPK TRANSPORT LTD. 001585125INVENIO RESEARCH & THERAPEUTICS INC. 002231992JOVONNE VINEYARD ESTATE LIMITED 002106613LRG RECOVERY OPERATIONS LTD. 002263429METRO.ISP INC. 001222903MILICOR TECHNOLOGY INC. 000645558MITECH SOLUTIONS INC. 002251559MR.OFFICE FURNITURE INC. 001707212NORTHSIDE AUTOMOTIVE GROUP INC. 002137544OAKTEK DATA DESIGN INC. 001190767

Page 11: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4397

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

PINE FARMS CYDER & FRUIT WINERY INC. 001563616PLO CONTRACTING INC. 001709143PREMIER LIVING REALTY INC. 001568536QUEEN SQA INC. 002010624SAI WOO LIMITED 000808727SANCHEZ ROOFING SERVICES INC. 002152735SL PROPERTY HOLDINGS LTD. 002129715VAAL HOLDINGS INC. 001302428W.B. MIKKELSEN HEATING & COOLING LTD. 000848521WHY? JEWELLERY INC. 001676657Z’S PAINTING AND CONTRACTING INC. 0017262891609844 ONTARIO LTD. 0016098441671999 ONTARIO INC. 0016719992052178 ONTARIO INC. 0020521782110291 ONTARIO INC. 0021102912146635 ONTARIO INCORPORATED 0021466352163447 ONTARIO INC. 0021634472176636 ONTARIO INC. 002176636348296 ONTARIO LIMITED 000348296539997 ONTARIO INC. 0005399972011-11-09ACUMEN CONSULTING INC. 001414973BEST PROFESSIONAL MANAGEMENT & TRADING COMPANY LIMITED 000636049BLACK PEN GROUP INC. 002208560BURLINGTON NUCLEAR IMAGING INC. 000807755CATHY & J.P. ENTERPRISES LTD. 000569100DIETRICH PLUMBING INC. 001235031EUROPEAN GROCERIES LTD. 001187788FERME CAYER & FRERES INC. 000494505FIRST MEDICAL SUPPLY LTD. 001573492GALAMAX INC. 002052652HAYS & STEMMANN BAR-B-QUE CATERING LTD. 000330452HENDRIK TOOL & DIE INC. 001243225K H CARRIER INC. 001482891LAKE OF BAYS HOLDINGS LIMITED 000330450LINDNER BRAND CORPORATION 001816912NEW THERMO WINDOWS OF CANADA INC. 000964752NORTHERN BRIDGES INC. 001486339NORTHERN COOL SPRING (NORTH BAY) LTD. 000882227R.D. LEDUC CONSULTANTS INC. 001041233RUBICON EDUCATION INC. 001528183RUSSO FOOD INTERNATIONAL LTD. 001247675SCHAFER GROUP INC. 001293203ST. SAVA’S RADIO STATION INC. 000999541TECHNIX SOFTWARE SOLUTION INC. 0020943541267810 ONTARIO LTD. 0012678101284648 ONTARIO INC. 0012846481334734 ONTARIO INC. 0013347341373115 ONTARIO INC. 0013731151420278 ONTARIO INC. 0014202781466943 ONTARIO LTD. 0014669431571175 ONTARIO INC. 0015711751590612 ONTARIO LTD. 0015906121596727 ONTARIO INC. 0015967271746386 ONTARIO INC. 0017463861750809 ONTARIO INC. 0017508092103729 ONTARIO INC. 0021037292131048 ONTARIO INC. 00213104866 WELHAM INC. 001725934737816 ONTARIO INC. 000737816748405 ONTARIO INC. 000748405918682 ONTARIO LIMITED 0009186822011-11-10CAPO AUTO SERVICES INC. 002082067HUTNER TRADING CORPORATION 000058783

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

NESHER CONSTRUCTION & SERVICES INC. 001611091PROFESSIONAL GST REFUND LIMITED 002064660PROJECT GREENLIGHT LIMITED 002161421SOLD OUT INC. 002214035SUPER SAM BARBER SHOP INC. 001278215THE LITTLE COMPUTER SHOP INC. 0012467591100377 ONTARIO INC. 0011003771210865 ONTARIO INC. 0012108651232275 ONTARIO INC. 0012322751236134 ONTARIO INC. 0012361341516422 ONTARIO INC. 0015164221639957 ONTARIO CORPORATION 0016399572069998 ONTARIO INC. 0020699982011-11-152258040 ONTARIO INC. 0022580402011-11-18STREAMLINE AUTO REPAIR INC. 0015133662011-11-21CEREMONIES TO REMEMBER INC. 002213759OCEAN ROCK PROPERTIES INC. 001182133R & C INTERNATIONAL CONSULTANTS INC. 0020876192011-11-23KALLEN PROPERTIES INC. 0009827802011-11-24COLES ENTERPRISES OF BELLEVILLE INC. 000531682EMERGENCY SERVICE TRAINING PROGRAMS LTD. 000942521THE FIRST AID TRAINING COMPANY INC. 0015096522011-11-252230306 ONTARIO LTD. 0022303062011-11-27TROPICAL COFFEE INC. 0016231222011-11-28ACEPLUS ENTERPRISE LIMITED 001135967IMAGINATIVE MINDS INC. 002053130872476 ONTARIO LIMITED 000872476895324 ONTARIO LIMITED 0008953242011-11-29BENJAMIN JAMES MARKETING COMMUNICATIONS INC. 002045168JAGLYN ENTERPRISES INC. 000592265NEW STAR FINANCE (CANADA) INC. 0017570422011-11-30B J MILLS CONSULTING INC. 001146473CASA AZZURRI TRATTORIA INC. 001710946DIETRICH PUDDY & ASSOCIATES INC. 001016164DOJA CORP. 000647826KRONOS MANUFACTURING INC. 002016045PRIME ONLINE PROMOTING CORP. 001800624R. L. MCPHERSON & ASSOCIATES INC. 000335629645512 ONTARIO LTD. 000645512990046 ONTARIO INC. 0009900462011-12-01BROOKPARK HOLDCO INC. 002131128F.R. INTERNATIONAL GROUP (CANADA) INC. 002166152FUSER MEDIA GROUP INC. 002286685HAMILTON INSULATION SERVICES INC. 001527836JOHNSTON MEDIA GROUP INC. 002286680KAPAREL CORPORATION 001353959LEAPBRAIN INC. 002217937MENDX ASSOCIATES INC. 001247729NJ DISTRIBUTORS INC. 001766082ROCKIE YU INSURANCE AGENCY LIMITED 001199459TORMART LEASING INC. 000893311WAVERLEY HOTELS (PORT ARTHUR) LIMITED 000948848WELLINGTON MEDIA GROUP INC. 0022866821140574 ONTARIO INC. 001140574

Page 12: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4398 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

1299654 ONTARIO INC. 0012996541530678 ONTARIO INC. 0015306781541067 ONTARIO INC. 0015410671555973 ONTARIO INC. 0015559731781875 ONTARIO INC. 0017818752119686 ONTARIO LIMITED 0021196862228225 ONTARIO LTD. 002228225503304 ONTARIO INC. 0005033042011-12-02BIG STONES HAULAGE AND TRUCKING INC. 002012882BK RETAIL CO. INC. 002081780BRENT GATES INC. 002088278CHARLCO HOLDINGS (CANADA) INC. 001225265CITY TIRE INC. 002166551DEWIDALE FARMS LTD. 000533156GREAT EASTERN HOLDINGS LTD. 001690411ILLUSTRIOUS TRADING COMPANY LTD. 001583271JEN JU 101 LTD. 002148301LONG SHOT PICTURES INC. 001319632MICHELLE & LIN LTD. 002126035NYR DEVELOPMENT CORPORATION INC. 001247931RIVERSIDE STABLE LTD. 000750026THE DISCOUNT WAREHOUSE LTD. 002224060THE INSURANCE CENTRE INC. 001622397TRAILER MART (1995) LTD. 001134585WOOD JOHNSON HOLDINGS LTD. 0017473821095985 ONTARIO LIMITED 0010959851173244 ONTARIO LIMITED 0011732441191024 ONTARIO LIMITED 0011910241307116 ONTARIO LIMITED 0013071161656632 ONTARIO LTD. 0016566321788275 ONTARIO LIMITED 0017882752058281 ONTARIO INC. 0020582812180647 ONTARIO INC. 0021806472268670 ONTARIO INC. 0022686702011-12-05ADVANCE AIRPORT LIMO SERVICE INC. 002151099ATCO CONSTRUCTION LTD. 001478804BALASARAH INC. 001222328CASSELS MONAGHAN VENTURES INC. 001763367CHARENE INVESTMENTS LIMITED 000290713CHAVERO METAL INTEGRATIONS INC. 001459213DRAKE TAVERN (WINDSOR) LIMITED 000679769E & D JAQUITH ENTERPRISES LTD. 000715652ECLIPSE DANCE INC. 002052217ELITE DC SOLUTION INC. 002151247HANFLO CORPORATION 002014805LORNA FASHION & ACCESSORIES LTD. 001086351MARSH ENGINEERING LIMITED 000317551MCSTEEVCO INCORPORATED 001699395MEDICAL DENTAL DATA SYSTEMS LTD. 000440033PATHMARK PROFESSIONAL SERVICES INC. 001744510SIDSWORTH INVESTMENT CORPORATION 000895929THORNMARK ESTATES LIMITED 000228305WALDOR CONSULTING SERVICES INC. 0006560081413226 ONTARIO LTD. 0014132261529213 ONTARIO INC. 0015292131766351 ONTARIO LTD. 0017663512013282 ONTARIO LIMITED 0020132822037259 ONTARIO INC. 0020372592110139 ONTARIO LIMITED 0021101392110140 ONTARIO LIMITED 0021101402136812 ONTARIO INC. 0021368122261718 ONTARIO INCORPORATED 002261718545663 ONTARIO LIMITED 000545663604492 ONTARIO INC. 000604492

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

867805 ONTARIO LIMITED 000867805905396 ONTARIO LIMITED 0009053962011-12-06AFRICAN MARIMBA INC. 001308965AKSA HOLDINGS INC. 001623078ASC STRATFORD INC. 002165872AURORA EXECUTIVE INVESTCO LTD. 002133367CENTURY 21 FORALL REALTY LTD. 000369477DAVID LEDGLEY HOLDINGS INC. 000646916DOGAL HOLDINGS INC. 000987241G. WHITE LEAN CONSULTING INC. 002229244GEORGE J. PARKER PROFESSIONAL CORPORATION 001687800KING-WES HOLDINGS LIMITED 000695785KNIGHT HOLDINGS INC. 000598963KWST CONSULTING CORPORATION 001235728M & S LAWN CARE & SNOW REMOVAL INC. 002169495MEDICARE GROUP INC. 001857426MOORE TOOL & MOTOR SERVICE (LONDON) LIMITED 000359182N. GRAYSON DRUGS LIMITED 000409685RONWALD BUILDING LTD 000830454SAEED TRADING LTD. 001632246SEVILLE SALON SYSTEMS INC 000808404ST. CLEMENTS AUTO BODY LTD. 000372120UJKA FLOORING LIMITED 001860739VALROSE PROPERTIES LIMITED 001247687VINTAGE WINE KING INC. 001828601WHIRLPOOL CANADA ACQUICO (2009) INC. 0022247241050059 ONTARIO INC. 0010500591475113 ONTARIO INC. 0014751131609065 ONTARIO INC. 0016090651668229 ONTARIO LIMITED 0016682292092631 ONTARIO LTD. 0020926312099235 ONTARIO INC. 0020992352175894 ONTARIO INC. 0021758942198019 ONTARIO INC. 002198019615317 ONTARIO LIMITED 000615317794568 ONTARIO LTD. 000794568973816 ONTARIO INC. 0009738162011-12-07ALTERNATIVE STRUCTURES INCORPORATED 001271433CHURCH MOBILE HOME PARKS & DEVELOPMENTS (BARRIE) LIMITED 000239200EXCLUSIVE INTERNATIONAL TRADERS INC. 002136757GMRD INVESTMENTS LTD. 000473559GREATSON INTERNATIONAL (CANADA) LTD. 002105080GREENFIELD FACTORING INC. 002202286H.A. HOLDINGS LIMITED 001642683IPRO INVESTMENT CORPORATION 001718380JOHNSTOWN AGRI-BUSINESS G.P. INC. 002160617KHALSA TRANSPORT LTD. 001760905MAXFIELD’S JEWELLERS LTD. 001425055REEL TURF GOLF EQUIPMENT SERVICE INC. 001715597RICHBRIDGE LTD. 001593234SHERIF COSMETICS INC. 0022640481335691 ONTARIO LIMITED 0013356911335692 ONTARIO LIMITED 0013356921375470 ONTARIO INC. 0013754701762748 ONTARIO INC. 001762748

katHerine m. murrayDirector, Ministry of Government ServicesDirectrice, Ministère des Services

(144-G620) gouvernementaux

Page 13: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4399

Cancellation for Cause (Business Corporations Act)

Annulation à juste titre (Loi sur les sociétés par actions)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that by orders under section 240 of the Business Corporation Act, the certificates set out hereunder have beencancelled for cause and in the case of certificates of incorporation thecorporations have been dissolved. The effective date of cancellation precedes the corporation listing.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, par des ordres donnés en vertu de l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions,lescertificatsindiquésci-dessousontétéannulésàjustetitreet,danslecasdescertificatsde constitution, les sociétés ont été dissoutes. La dénomination sociale des sociétés concernées est précédée de la date de prise d’effet de l’annulation.

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

2011-12-13KEITH PROWSE CANADA LIMITED 12317811812796 ONTARIO INC. 1812796

katHerine m. murray(144-G621) Director/Directrice

Erratum Notice Avis d’erreur

ONTARIO CORPORATION NUMBER 1018345

Vide Ontario Gazette, Vol. 143-36 dated September 4, 2010

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the notice issued under section 240 of the Business Corporations Act set out in the September 4, 2010 issue of the Ontario Gazette with respect to Jones Airconditioning and Heating Ltd. was issued in error and is null and void.

Cf. Gazette de l’Ontario, Vol. 143-36 datée du 4 septembre 2010

PAR LA PRÉSENTE, nous vous informons que l’avis émis en vertu de l’article 240 de la Loi sur les sociétés par actions et énonce dans la Gazette de l’Ontario du 4 septembre 2010 relativement à Jones Airconditioning and Heating Ltd. a été délivré par erreur et qu’il est nul et sans effet.

katHerine m. murray(144-G622) Director/Directrice

Notice of Default in Complying with the Corporations Information Act Avis de non-observation de la

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

NOTICE IS HEREBY GIVEN under subsection 241(3) of the Business Corporations Act that unless the corporations listed hereunder comply with the filing requirements under the Corporations Information Act within 90 days of this notice orders dissolving the corporation(s) will be issued. The effective date precedes the corporation listings.

AVIS EST DONNÉ PAR LA PRÉSENTE que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés

mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés. La date d’entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

Name of Corporation:Dénomination socialede la société:

Ontario Corporation NumberNuméro de la

société en Ontario

2011-12-13UPWARD MOTION INC. 1312079

katHerine m. murray(144-G623) Director/Directrice

Marriage Act Loi sur le mariage

CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRATION as a person authorized to solemnize marriage in Ontario have been issued to the following:

LES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT PERMANENT autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants:

November 28, 2011 to November 30, 2011

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Porter, Robert George Brown Lyndhurst, ON 30-Nov-11Rodrigues, Margaret Toronto, ON 30-Nov-11Ahn, Do Hwan Peterborough, ON 30-Nov-11Chai, Wansoo Richmond Hill, ON 30-Nov-11Betts, Douglas D Kitchener, ON 30-Nov-11Moore, Donald J Ariss, ON 30-Nov-11Tilstra, Virginia M Cavan, ON 30-Nov-11Hawley, Katherine Louise Wallaceburg, ON 30-Nov-11Hagen, Jason F Scarborough, ON 30-Nov-11Bell, Brian J Oshawa, ON 30-Nov-11Trivers, Jane Alice Fort Frances, ON 30-Nov-11Ramirez, Carmen R Mississauga, ON 30-Nov-11Ardill, Ian Taylor Newmarket, ON 30-Nov-11Chedid, Youssef Toronto, ON 30-Nov-11Gan, Li Zu Markham, ON 30-Nov-11Mbugua, William Njenga Toronto, ON 30-Nov-11Zapata Bejarano, Washington Vinicio

Toronto, ON 30-Nov-11

Moncrieffe, Peter Anthony Toronto, ON 30-Nov-11Whatley, Timothy Mark Durham, ON 30-Nov-11Schochet, Dov Yehuda Toronto, ON 30-Nov-11

RE-REGISTRATIONS

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Moledina, Nazib Ottawa, ON 28-Nov-11

Page 14: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4400 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

CERTIFICATES OF TEMPORARY REGISTRATION as person authorized to solemnize marriage in Ontario have been issued to the following:

LES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT TEMPORAIRE autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants:

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Choong, Norbert Kai Chong Albuquerque, NM 30-Nov-11November 15, 2012 to November 19, 2012

CERTIFICATE OF CANCELLATION OF REGISTRATION as a person authorized to solemnize marriage in Ontario have been issued to the following:

LES AVIS DE RADIATION de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à:

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Singh, Kabal Mississauga, ON 28-Nov-11Swan, Darbara S Toronto, ON 28-Nov-11Biesheuvel, Barend Madoc, ON 28-Nov-11Ellarby, Catherine G Brampton, ON 28-Nov-11Gilroy, Ross A Etobicoke, ON 28-Nov-11Irwin, Katherine P Etobicoke, ON 28-Nov-11Sinclair, Janet Orangeville, ON 28-Nov-11Northup, Michael Andrew Oakville, ON 28-Nov-11Royce, Robert Hamilton, ON 28-Nov-11

Sandra leonettiDeputy Registrar General

(144-G624) Registraire générale adjointe de l'état civil

CERTIFICATE OF PERMANENT REGISTRATION as a person authorized to solemnize marriage in Ontario have been issued to the following:

LES CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT PERMANENT autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants:

December 5, 2011 to December 9, 2011

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Choi, You Min Richmond Hill, ON 07-Dec-11Balasingham, Kesavan Toronto, ON 07-Dec-11Layne, Ashley Emmanuel Onester

Cambridge, ON 07-Dec-11

Grimes, Jason Tillsonburg, ON 07-Dec-11Garcia, Miguel A Barrie, On 07-Dec-11Carman, Thomas Joseph Windsor, ON 07-Dec-11Laing, Manuel Robert Windsor, ON 07-Dec-11Wiesel, Richard W Cambridge, ON 07-Dec-11Hagan, Mary Frances London, ON 07-Dec-11Ristau, Harold Angus, ON 07-Dec-11Boltauzer, Branko-Janez Huntsville, ON 07-Dec-11Okafor, Collins Udoka Courtice, ON 07-Dec-11Guillemette, Nil Pembroke, ON 07-Dec-11Egoda-Gedara, Brian Toronto, ON 07-Dec-11Hart, Kevin Holyrood, ON 07-Dec-11Wheaton, Andrea Barrie, On 07-Dec-11Gyimah, Cynthia Woodbridge, ON 07-Dec-11Byers, Jason L Ottawa, ON 07-Dec-11Osmani, Muhamed Halim Etobicoke, ON 08-Dec-11Van Holst, Cornelis Ronald Ottawa, ON 09-Dec-11

RE-REGISTRATIONS

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Wachenschwanz, Donald Cornwall, ON 08-Dec-11Ferguson, Bill C Kingston, ON 08-Dec-11

CERTIFICATE OF CANCELLATION OF REGISTRATION as a person authorized to solemnize marriage in Ontario have been issued to the following:

LES AVIS DE RADIATION de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à:

NAME LOCATION EFFECTIVE DATE

Reid, Robert Barrie, ON 07-Dec-11Bruce, Holly F Whitby, ON 07-Dec-11Murrin, Stephen Mississauga, ON 07-Dec-11Nirappel Joseph, Philip Mississauga, ON 07-Dec-11Smith, Michael A Pembroke, ON 07-Dec-11Chambers, Steven J Kingston, ON 07-Dec-11Hayward, Elizabeth Kingston, ON 07-Dec-11Schmolka, Diane Ottawa, ON 07-Dec-11Shepherd, David J Ottawa, ON 09-Dec-11

Sandra leonettiDeputy Registrar General

(144-G625) Registraire générale adjointe de l’état civil

Change Of Name Act Loi Sur Le Changement De Nom

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following changes of name were granted during the period from November 28, 2011 to December 04, 2011, under the authority of the Change of Name Act, R.S.O. 1990, c.c.7 and the following Regulation RRO 1990,Reg 68). The listing below shows the previous name followed by the new name.

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE donné que les changements de noms mentionnés ci-après ont été accordés au cours de la période du 28 novembre 2011 au 04 décembre 2011, en vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, chap. C.7, et du Règlement 68, R.R.O. 1990, s’y rapportant. La liste indique l’ancien nom suivi du nouveau nom.

PREVIOUS NAME NEW NAMEAGORILLA, ARTHUR.A. BALBOA, VICTOR.AL-MASSRAF, ASSER. ALMASSRAF, ACER.ALEXANDER, MARCO. KULA, MARK.ANDAN, TAMARA.. VEBER, TAMARA..AQUA AQALLAL, ALEXANDRE. AQALLAL, AMINE.ASHRAFI-KERAHROUDI, AMIR.HOSSAIN. ASHRAFI, AMIR.ASTRAFALLIE, MOHAMED.SHANAZALI. ASTRAFALLIE, SHAWN.BAKER, KYLE.WILLIAM.JAMES.

BLANCHARD, KYLE.WILLIAM.JAMES.

BALINT, SZILVIA. TAMAS, SZILVIA.BAMBAH, SONAKSHI. BAMBAH, SONIA.RIALCH.

BOOTS, CATHERINE.JOYCE.BOUCHER, CATHERINE.MELODIE.ELIZABETH.

BOUGKOS, JOHN. BUSGOS, JOHN.BROWNLIE, JACOB.PHILLIP.ALEXANDER.

WALTERHOUSE, JACOB.PHILLIP.ALEXANDER.

BUTLER, DAVID.GORDON. SLATER, DAVID.GORDON.

Page 15: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4401

PREVIOUS NAME NEW NAMECELLINI, SIMAN.ARUN. ANDREWS, CELLINI.CHAN, WEI-QUAN. CHAN, BENNY.WEI.QUAN.CHAUDHARI, HONEY.SINGH. CHAUDHARI, RANVIR.SINGH.CHUANG, JUN. CHUANG, JUNE.CONCEPCION, GINA.FLORESCA. SARMIENTO, GINA.COOPER, TINA.MARIE. MC INTYRE, TINA.MARIE.COULOMB, JOSEPH.ROBERT.ANDRÉ.

COULOMBE, ANDRÉ.ROBERT.JOSEPH.

CRANDALL, PHILIP.DAVID.GATES-CRANDALL, PHILIP.DAVID.

D’AMICO, FRANCIN. D’AMICO, FRANCINE.DADEY, EDWIN.K. GODWIN, DAVID.K.DADEY, VESTA. GODWIN, KATE.E.DANCEL, RUBY.MILLADO. RIPLEY, RUBY.MILLADO.DENNEY, LAURA.JANE. BUTLER, LAURA.JANE.DONKOR, GERTRUDE.SUSANA. GODWIN, GERTRUDE.Y.ELIATHAMBY, SHRANIKHA.ALAKSHI.

KUKANESAN, SHRANIKHA.ALEXA.

EULETTE, TANIKA.ARIEL.FRIESEN.

EULETTE, ARIEL.TANIKA.FRIESEN.

FAIROOZ, NAFIZA. UDDIN, NAFIZA.FAIROOZ.FINUCAN, COLE.KENNETH. IALENTI, COLE.KENNETH.FOK, TSZ.CHUN. FOK, TSZ.CHUN.SAMPSON.FOK, TSZ.CHUNG. FOK, TSZ.CHUNG.FREDDY.FOX, LAURA.YVONNE. SMITH, LAURA.YVONNE.FRANCE, YVES-MARIE. FRANCE, VICTORIA.FUAD, S.M.NAFIS. UDDIN, S.M.NAFIS.FUAD.GAKHAL, PAMELA.KAUR. BAINS, PAMELA.KAUR.

GATES, TREVOR.GRANT.GATES-CRANDALL, TREVOR.GRANT.

GIBSON, EVAN.JAMES. HOPKINS, EVAN.JAMES.GOGEK, EDWARD.JOSEPH. FAIR, TED.GOOGOO, ALEXIS.HAILEY.SKY.

GILMORE, ALEXIS.HAILEY.SKY.

GREER, NATHALIE.ASHLEY. GREER, ÉMILE.NATHANIEL.HAIDER, AZAR.MIDOKHT. RASHVAND, AZAR.MIDOKHT.HAMEEDA, HAMEEDA. FAIZI, HAMEEDA.HAMOEN, GABRIEL.WILLIAM. MOON, GABRIEL.WILLIAM.HAMOEN, TREVOR.JACOB.ROY. MOON, JACOB.TREVOR.HANSLOD, SOUKAT. HANSLOD, SHAUKAT.

HASHEY, STEPHANIE.JEAN.ASHLEY-STONE, STEPHANIE.JEAN.

HENDERSON, SUSAN.IRENE. KOPPISCH, SUSAN.IRENE.

HENRY, ASHLEE.ROSALEE.FARNSWORTH, ASHLEE.ROSALEE.

HO, REBECCA.LAI.MAN. CHAN, REBECCA.LAI-MAN.HOLLEBRANDSE, JOHANNES. HOLLEBRANDSE, JOHN.HORNAK-D’ARPINO, STEVEN.ALDO. D’ARPINO, STEVEN.ALDO.HOULE, ERIC.JAMES. HOULE, COTTON.JAMES.HOUSE, MARIE.EDNA. PURDY, MARIE.EDNA.HUANG, TIAN.YU. HUANG, TONY.TIANYU.IBRAHIM, SARAH. KHAJOUIAN, SARAH.IFRIM, DANUT. IFRIM, DAN.IQBAL, SUALEH. SAIGAL, SWALEH.IRESON, DANIEL.EDWARD. ANGRIGNON, DANIEL.

PREVIOUS NAME NEW NAMEJACOBS, MARK.WELLINGTON. JACOBS, MARC.WELLINGTON.JAGDEO, ARMAAN.SINGH. JAGDEY, ARMAAN.SINGH.JAGDEO, BAVLEEN.KAUR. JAGDEY, BAVLEEN.KAUR.JAGDEO, GURSHAWN.SINGH. JAGDEY, GURSHAWN.SINGH.JAGDEO, YADVINDER.SINGH. SINGH, YADVINDER.JAVED, AHMED.KAIMKHANI. AHMED, JAVED.KAIMKHANI.JOHNSTON, CHLOE.LYN. ALLAHAM, CHLOE.LYN.JONES, JESSICA.LEE. NICHOLSON, JESSICA.LEE.KENNEDY, SHAUNA.ASHLEY. LE DREW, SHAUNA.ASHLEY.KIM, SO.YEON. KIM, JENNY.JAEYEON.KIM, SUNKEONG. CHA, JANICE.SUNKEONG.KODITUWAKKU, NIDARSHA. RAMDEHOLL, NIDARSHA.KOTSOPOULOS, KRISTEN.ALEXANDRA.

PRUFROCK, KRISTEN.ALEXANDRA.

KRAVCHINSKY, RINA. KRAVCHINSKY, RIMMA.KUMAR, SIMAN.ARUN. ANDREWS, SIMON.KUSY, ASHLEY.BROOKE. WILSON, ASHLEY.BROOKE.LAPERLE, LINDA. CHOLETTE, LINDA.LAROSE-CLARKE, BRADLEY.PETER. CLARKE, BRADLEY.PETER.LAZAREVIC, ALEKSANDRA. GULRAJANI, ALEKSANDRA.LEE, MING.HAN. LEE, SEAN.MING-HAN.LEE, SUK.BIN. LEE, ANDY.SUKBIN.LEPAGE, TAWNY.MARIE. LEPAGE, LENNOX.LEWANDOWSKI, FRANCISZKI. LEWANDOWSKI, FRANCINE.LI, PING.WEN. LI, FRANK.LIN, WEN. LIN, EVELYN.

LLOYD, ANDREW.WILLIAM.DIAMOND, ANDREW.WILLIAM.

LLOYD, NORMA.ELAINE. DIAMOND, NORMA.ELAINE.LOPES, KRISTA.MARIE. HOLMES, KRISTA.MARIE.LU, DAN.THACH. LU, ANDY.DAN.THACH.LU, YAO.YUE. LU, JENNY.YAOYUE.LYNCH HARWOOD, ELIZABETH.ANN... LYNCH, ELIZABETH.ANN...MAC PHAIL, KYLA.ELISABETH..

CORRIVEAU, KYLA.ELISABETH..

MACDONALD, LEAH.GLOVER.. RAYMER, LEAH.GLOVER..MACHACYNSKI-MORRISON, MAKAYLA.KRISTEN.NEVAEH. HENDERSON, ALIYAH.GRACE.MACKAY, ELAINE.JUDITH. SAUNDERS, ELAINE.JUDITH.MALUPANGUE, JESLIE.CULIAO. KREIGER, JESLIE.CULIAO.MAND, MANDHEERAJ.SINGH. MAND, DHEERAJ.SINGH.MC COY, RHONDA.JOAN.MARIE.

SLONGO, RHONDA.JOAN.MARIE.

MCCLINTON, KIRSTEN.HOLLY.DEANNA.

MONTGOMERY, KIRSTEN.HOLLY.DEANNA.

MCPARLAND, WILLIAM.KELLY. MCPARLAND, KELLY.MOHAMMAD BIGLAR, FARBOD. BIGLAR, FARBOD.MOHAMMAD TAHIR, OMED. AHMADY, OMED.MOHAMMED, CARISSA.SHANIA. HEWITT, CARISSA.SHANIA.MOHINDRA, ARVIN. SHIVAL, JAG.MOORE, BARBARA.ANNE. SHEEHAN, BARBARA.ANNE.

MUHUNTHAN, VANATHY.MAHENDRANATHAN, VANATHY.

Page 16: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4402 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

PREVIOUS NAME NEW NAMEMUSTAFA, MOSTAFA. MUSTAFA, DRAKE.NG, WING.KIN. NG, FRANK.WING.KIN.NG, WOON.YEE. ENG, WINNY.WOON-YEE.NGAI, SUET-YEE.SALLY. NGAI, SALLY.SUET-YEE.NGUYEN, DAVID. LEE, DAVID.NKETIA, KENNETH.NANA. NKETIA, KENNETH.KWAKU.NORRIS, KIMBERLY.LORNA. NORRIS, KYMBERLY.LORNA.OH, JUNG.HYE. OH, KATE.JUNGHYE.PARADA, JENNIFER.LETICIA. JOHNSON, JENNIFER.LETICIA.PARK, KYU.YOL.EDWARD. PARK, EDWARD.KYU.YOL.PELLERIN, JOSEPH.CLAUDE. PELLERIN, JEAN-CLAUDE.PERRUZZA, RESTITUTA. PERRUZZA, LISA.LOUISE.PETERS-BOOTS, CORY.ALEXANDER.

BOUCHER, CORY.ALEXANDER.

PETERS-BOOTS, TIMOTHY.RYAN. BOUCHER, TIMOTHY.RYAN.PETERSON, DAYNA.ROD. RODRIGUES, DAYNA.ANNE.PETIT-HOMME, ED-ESTHER.MICHÈLE. KENGA, ED-ESTHER.MICHÈLE.PHAN, PHUONG.NGOC. PHAN, MARY.

PIATKA, OKSANNA.MIROSIA.PIATKA, SANDRA.OKSANNA.MIROSIA.

POOPALASINGAM, JEYALUXMY.

THAVACHANDREN, JEYALUXMY.

PROUDFOOT, EMMA.ELIZABETH. VINNAI, EMMA.ELIZABETH.

QUENDT, GABRIELLA.GRACE.STICKLEY, GABRIELLA.GRACE.

RATANAMONGKOLMAS, NAIYANA. SAMARNPHARB, NAIYANA.RAVARY-SAUVÉ, MARIE.JOSÉE.JAYME. RAVARY, MARIE.JOSÉE.JAYME.ROCHA-DUCE, VICTORIA.MARTINA. ROCHA, VICTORIA.MARTINA.ROYLANCE, THERESA.MARIE.LOUISE.

MANCHESTER, THERESA.MARIE.LOUISE.

SADOWSKA, BEATA.SADOWSKA-KAAS, BEATA.EWA.

SARTORETTO, DANIEL.SARTORETTO, DANIEL-MICHAEL.

SATKUNASIVAM, NAGARAJESHWARAN. SATKUNASIVAM, RAJ.SHAMS LARIJANI, SHAHDAD. SHAMS , SHAHDAD.SHAN, NEW.BOY. SHAN, JOSHUA.APRIL-HTOO.SHANE, MEGHAN.CATHERINE. WOOD, MEGHAN.CATHERINE.SHARIF, WARDA.ABUKAR. ABUKAR, SULEEQO.SHEIKH.SHARMA, NEEHA.PRASHER. SHARMA, NEHA.PRASHER.SHETH, HIMADRI.JITENDRA. SHETH, HIMADRI.SIMON, NIDHI. ANDREWS, NIDHI.SINGH, DALVINDER.KAUR. SIBIA, DALVINDER.KAUR.SINGH, HARDEEP. SIBIA, HARDEEP.SINGH.SINGH, HARVIR. SIBIA, HARVIR.SINGH.SINGH, PORTIA.PADMAWATIE. FOX, PORTIA.FERNANDES.SISIAN, IRINA. IOVU, IRINA.SLOAN, ELLA.JO.ANNE.MARY. DRAAK, SCHATZ.SMALL, STACY.DIANE. COLLISON, STACY.DIANE.SMITH, ROBYN.TERESA. UNDERHILL, ROBYN.TERESA.ST-AMOUR, STEVEN.SELDON. RAMALHO, STEVEN.SELDON.STABILE, SILVIA. STABILE, PHILIP.ORESTE.STEWART-SPENCE, RILEY.JOSEPH. PIAT-SPENCE, RILEY.JOSEPH.

PREVIOUS NAME NEW NAMESU, JIONG.HAO. SU, JIMMY.SUH, EUN.SOOK. SUH, JESSICA.EUN.SOOK.SULTANA, AFROZA. UDDIN, AFROZA.SULTANA.SULTANA, NYEEMA.PROBA. UDDIN, NYEEMA.PROVA.SURESHA, SAVITHA. KUMAR, SHREYA.SUTOR, ZEPUR. APELIAN-SUTOR, ZEPUR.TAILOR, AMITABEN.RAKESH. SURTI, AMITA.SNEHAL.TALEBI, AFSANEH. ABEDI, AFSANEH.TANNER, HILARY.CAROL.LYNNE. ROSE, HILARY.CAROL.LYNNE.

TOPIWALA, PAYAL.Y.TOPIWALA, PAYAL.BHAVINKUMAR.

VEZINA, PIPER.MICHELLE.SHELLEY. EDWARDS, PIPER.JEANNETTE.VUKAS, ANTE. VUKAS, ANTON.ANTE.WADDELL, PATRICIA.DOROTHY.

RUSSELL, PATRICIA.DOROTHY.

WALSH, LIAM.JOSEPH. SHIELS, LIAM.JOSEPH.WEBER, SARA.MICHAL. PLONKA, SARA.MICHAL.

WEISDORF, LILLIAN.ROSE.FRIEDLANDER, LILLIAN.ROSE.

WHITTEN, MORGAN.ALEXANDRE.DONALD.

O’NEILL-WHITTEN, MORGAN.ALEXANDRE.DONALD.

WIJAS, CAROLINE.KARIN. FERANC, CAROLINE.KARIN.

WILSON, DARRYL.ROBERT.VALENTINE, HARLEY.DARRYL.ROBERT.

YAN, YOU.JIA. YAN, AMY.YOUJIA.ZAKOWSKI, SUSAN.JANE. YETMAN, SUSAN.JANE.ZHANG, CHUNYAN. ZHANG, KAY.CY.ZHANG, QI. ZHANG, POLLY.QI.ZHOU, HUIJIE. ZHOU, JIMMY.HUIJIE.ZIATYK, TERRY. TYLER, TERRY.JAMES.

Sandra leonettiDeputy Registrar General

(144-G626) Registraire générale adjointe de l’état civil

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the following changes of name were granted during the period from December 05, 2011 to December 11, 2011, under the authority of the Change of Name Act, R.S.O. 1990, c.c.7 and the following Regulation RRO 1990,Reg 68). The listing below shows the previous name followed by the new name.

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE donné que les changements de noms mentionnés ci-après ont été accordés au cours de la période du 05 décembre 2011 au 11 décembre 2011, en vertu de la Loi sur le changement de nom, L.R.O. 1990, chap. C.7, et du Règlement 68, R.R.O. 1990, s’y rapportant. La liste indique l’ancien nom suivi du nouveau nom.

PREVIOUS NAME NEW NAMEABDUL KARIM, AWAB.. KEARN, ALEX.ABDUL KARIM, MOHAMMAD.. KEARN, MATTHEW.ABDUL KARIM, NABIL.K. KEARN, NEB.ABDUL KARIM, NASAJ. KEARN, NATALIE..ABDUL KARIM, SALSABIL. KEARN, ISABELL.ABDUL RAHIM, SAMEER. PANAHI, SAMEER.ADEWUYI, ADEJUWON.OLUWAS.

OLOMOLA, ADEJUWON.OLUWASEYI.

AHMAD, EMAD. CHAUDHRY, EMAD.TAHIR.AHMED, MARWA. AZIZ, MARIAM.ADIL.AHMED, SAHAN. AARON, SHAHAN.ARIYATHURAIRAJAH, GURUSHAN. PRASANNA, GURUSHAN.

Page 17: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4403

PREVIOUS NAME NEW NAMEARULAMPALAM, CALEB.DAVID. PALAM, CALEB.DAVID.AYESHA, AYESHA. QURESHI, AYESHA.AZAM, MUHAMMAD.HAMZA. AZAM, HAMZA.BABAR, RUBY. JOHN, RUBY.BAKALYUK, OLEG.OLEGOVYCH. BAKALYUK, RYAN.JOHN.BALL, SARA.YVONNE. PAYNE, SARA.YVONNE.BARBOZA, ANDRES.MIGUEL. LUZARDO, ANDRES.MIGUEL.BARBOZA, CARLOS.ELIAS. LUZARDO, JOSEPH.ELIAS.BARR, JENNIFER.ANNE. LAHEY, JENNIFER.ANNE.BAZIL, AFLIN. ST JEAN, AFLIN.BERNABE, JOAN. BERNABE, JOANNE.CASTILLO.BETTENCOURT, DYLAN.JAMES. LACE, DYLAN.JAMES.BHATTI, ZOHAIB.AYYAN.AZMAT. AZMAT, ZOHAIB.AYYAN.BIRZVILKIS, MICHEAL.NEIL. GALLAGHER, MICHAEL.BOZZER, MONIQUE.ROMA.MARIA. LEDREW, MONIQUE.BOZZER.BROWN, KRISTIE.ANNE.BEVERLEY.

FERRACCIOLI, KRISTIE.ANNE.BEVERLEY.

BRUNOE, CAROLANN. FRANCOEUR, CAROLANN.BURGIE, JEFFERY.CHARLES. LAROSE, JULIEN.JEFF.CAMUTI-ING, ANTONINO-JOSEPH.

ING, ANTONINO.JOSEPH.CAMUTI.

CAO, YA.FEN. WU, LINDA.CHATTERSON, ADAM.DAVID.STUART. GUZMAN, ADAM.CHAYRA, BIJOU.HARI. TEXEIRA, BIJOU.HARI.CHIGRIN, PHEDOR. CHIGRIN, JASON.CHULUUNBAATAR, BYAMBASUREN.

CHULUUNBAATAR, BIA.BYAMBASUREN.

CLELAND, ALLISON.NICOLE. LAROUCHE, ALLISON.NICOLE.

CLIFFORD, ALANA.KRISTA.ASHKENAZI, ZOLTAN-SHANI.SHENHAV.

COCKERTON, JULIE.ANNE. SHEARER, JULIAN.CROWLEY-D’HOLLANDER, KEVIN.IAN. D’HOLLANDER, KEVIN.IAN.CURTOSI, JENNIFER.PAULINE. GREY, JENNIFER.NICOLE.DA SILVA PEREIRA, DANIEL. PEREIRA, DANIEL.DA.SILVA.DA SILVA, ANA.PAULA.FERNANDES.

FERNANDES, ANA.PAULA.DA.SILVA.

DALE, SARAH.JANE.MARLENE.

DOWLING, SARAH.JANE.MARLENE.

DE JONG, CARINA.ESTER. BIJLSMA, CARINA.ESTER.DE SOUSA ARAUJO, CARLOS.NELSON. ARAUJO, NELSON.DECORTE, SARAH.MICHELLE. KOSKI, SAARA.MICHELLE.DENIS, ERIC.LANDON. ETHIER, ERIC.LANDON.DHIRANI, SALIM.SHAH. SHAH, SAMEER.DIXON, HUGH.MICHAEL. SIMPSON, MICHAEL.

ELAINE, EMEBET.LESLIE.DOBSON, ELENA.EMEBET.SISAY.

ELRAHEB, CHRISTINE.NABIL. GOURGY, CHRISTINE.NABIL.ERSKINE, ANDREW.RICHARD.LOUIS.

MISCHUK, ANDREW.RICHARD.LOUIS.

FANBULLEH, YOLANDA.AGYENIM BOATENG, YOLANDA.

FEARON, CHRISTIAN.JAMAL. FEARON, CHRISTIAN.JALEN.FEDERICO, ANDREW.GIUSEPPE.

FEDERICO, ANDREA.GIUSEPPE.

PREVIOUS NAME NEW NAMEGAMBLE, ALLISON.MARGARET.

O’CONNOR, ALISA.MARGARET.

GARIEPY, IRENE.LEONA.SCHOENBERGER, IRENE.LEONA.

GHOLAMALIZADEH, PUYAH. GHAPANCHI, MIKE.GIBSON, ISABEL.JAYANN. SHAWERA, ISABEL.JAYANN.

GIRIKIS, COSTANDINA.GIRIKIS-AGOLLI, COSTANDINA.

GRAPA, DOMINIKA. KURPIEL, DOMINIKA.GUTTERIDGE, YIXIN. FU-GUTTERIDGE, ZHONGLAN.HANONIK, ABDALLA. HANONIK, LEVON.HASSAN, GHASAK.A. KEARN, RONA.HAYES, KELLY.ANN. PAQUETTE, KELLY.ANN.HEIKAL, DOHA.MOHAMED.AS. HEIKAL, DOHA.HENLEY, THOMAS-LEE.JONES. HENLEY, THOMAS.LEE.JONES.HERNANDEZ FERNANDEZ, JASMINE. HERNANDEZ, JASMINE.HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRA.AYESHA.

HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO.DIEGO.

HODGKINSON, SYDNEY.LESYA. MCRAE, SYDNEY.LESYA.IDEMUDIA, EDWIN.OSANDREW.

IDEMUDIA, OSAMENDE.EDWIN.

JANKE, EMILY.LENA.MACHIN.WALKER, EMILY.LENA.MACHIN.

JANZER, JILL.MARIE. LUTES, JILL.MARIE.JORDAN, MATTHEW. TEWUH, MATTHEW.JORDAN.KALLIA, MAYURI. WESTON, MAYURI.MONIKA.KANKANAMGE, GAYAN.KAVEENDRA.

PREMACHANDRA, GAYAN.KAVEENDRA.

KANTARCIOGLU, BELMA. TULGA, BELMA.BELLA.KARUNANITHY, YALANI. THELAC, YALANI.KHANUNIK, LEON. HANONIK, LEON.

KHOMITSKA, ANGELA.JULIA.VANDERBEKE, ANGELA.JULIA.

KOWALEWSKI, NATHAN.DAVID. KOWALSKI, NATE.DAVID.KWON, SUNG.YEON. KWON, VICKI.SUNG-YEON.LI, FANG.DA. LI, FRANKLIN.LIANG, SHAO.QING. LIANG, SHIRLEY.LOZANO VERA DE KILLEN, INDIRA.RINA. KILLEN, INDIRA.YANAY.MACFARLANE, WENDY.PENKETH. PENKETH, WENDY.TURNER.MADRID, JENIFFER.BALBUENA.

MADRID-TONGOHAN, JENIFFER.BALBUENA.

MAHBOOBY, HARIS. MAHBOBI, HARASH.MAHBOOBY, MOHAMMAD.DAOUD.

MAHBOBI, MOHAMMAD.DAOUD.

MAHBOOBY, NARGIS. MAHBOBI, NARGIS.MAHBOOBY, PATOONEY. MAHBOBI, PATOONEY.MAHBOOBY, SADAF. MAHBOBI, SADAF.MAHBOOBY, SAHAR. MAHBOBI, SAHAR.MALAGA LOZANO, CARLO.JONATHAN. KILLEN, KARLO.JONATHAN.MALCHO, DENISE.ANN. LOSIER, DENISE.ANN.MANDERVILLE, JAMES.GATELY.

MANDERVILLE, JAMES.GATELY.STERLING.

MCROBERTS-MILNE, CARTER.MICHAEL. MILNE, CARTER.MICHAEL.MEMON, MOHAMMAD.FARID. SATTAR, FARID.M.MERCIER, SHARON.LOUISE. STORTZ, SHARON.LOUISE.

Page 18: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4404 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

PREVIOUS NAME NEW NAME

MERRITT, KEVIN.NEIL.DAVID.WESTWOOD-MORRIS, KEVIN.NEIL.DAVID.

MEUNIER, MICHELLE.PAUL.JOSEPH.

MEUNIER, MIKE.PAUL.JOSEPH.

MISETA, AGNES.NOEMI.SILVERHARBOUR, MEGAN.AGNES.

NADIR, MARYAM. ABDUL HUSSEIN, MARYAM.NAQVI, ADEEL.BABAR. JOHN, ADEEL.NAQVI, BABAR. JOHN, CARY.NAQVI, MISHAL.BABAR. JOHN, MISHAL.NAQVI, NABEEL.BABAR. JOHN, NABEEL.NARAINE, DASRAT.EISHWAR. NARAINE, NAVIN.DASRAT.

NDLOVU, AMAHLE.MITCHELL, RILEY.FAY.AMAHLE.

NIENHUIS, ETHAN.JOHN.MURRAY.

RUTHERFORD, ETHAN.JOHN.MURRAY.

NISHANTHAN, MATHANA. MAHENDRAN, MATHANA.ORAHA, ALLEN. HOZI, ELENA.YOUSUF.OWUSU, KWAME.ODURO. OWUSU, ODURO.BEN.PANWALA, RUHI.KIFLEN. KIFLEN, RUHI.PINHASOV, BELA. KOTYLEVA, BELLA.PREMACHANDRA, KANKANAMGE.UDARI.RUCHINI.

PREMACHANDRA, UDARI.RUCHINI.

PREMACHANDRA, MADDE.KANDAGE.DONA.

PREMACHANDRA, SUDARSHANI.MANEL.

RAFAELOVA, JESSICA. LIBERMAN, JESSICA.RAHNEMAY FARNOOD, EILA.YAN. FARNOOD, EILA.YAN.RANJBAR, AHMAD.REZA. RANJBAR, DANIEL.RANKIN-HIGGS, DUSTIN.JAMIE. HIGGS, DUSTIN.JAMIE.RAZAKARISOA, STEPHANIE.ALEXIA. CRANK, STEPHANIE.ALEXIA.RICHARDSON, DYLAN.COLE. PATERSON, DYLAN.COLE.RINGUETTE, JOSEPH.O’NEIL.GERARD. RINGUETTE, GERARD.O’NEIL.RIVERS-HAND, LOGAN.DAVID. MISKE, LOGAN.DAVID.HAND.ROBERTSON, DONNA.DARLENE.

ROBERTSON, DAWNA.DARLENE.

RUTTAN, EDWARD.SYLVESTER.

WILLIAMS, EDWARD.SYLVESTER.

SABO, DUSANKA. SAKIC, DUSANKA.

SADIQ, MUHAMMAD.ISMAIL.QURESHI, MUHAMMAD.ISMAIL.SADIQ.

SAPALO, JULIET.PURGANAN. TOTANES, JULIET.SAPALO.SAUNTHARARAJAN, NISCHA. SAUNTHAR, AHRENI.SEDIK, SELAHADIN. SEDIK, ADIEL.SHAFAGH-MOTLAGH, POUYA. FAIZI, POUYA.MOTLAGH.ST JACQUES, JENNIFER.JANE. JANE, JENNIFER.STACY, CHRISTINE. TEWUH, CHRISTINE.STACY.STONE, KALEB.DALTON.NOEL.

MISENER, KALEB.DALTON.DAVID.

SZABO, EDIT. SILVERHARBOUR, EDITH.SZETO, ANTHONY.MAN.KWONG. SZETO, ANTHONY.TAHIR, HAMDAN. CHAUDHRY, HAMDAN.TAHIR.TANG, JOSEPH.HO-KAI. TANG, HAO.JI.TAO, YUN. TAO, GLORIA.ZHENGZHENG.TAYYAB, FARRUKH. NOOR, FARRUKH.

PREVIOUS NAME NEW NAMETHOMPSON BABORAC, VOJISLAV.MICHEAL.GEORGE.THOMPSON.

THOMPSON, VOJISLAV.MICHEAL.

TOLSTOKOROVA, ELENA. BAY, LENA.

TRAN, VAN.THANG.GREEN-LEWIS, VAN.THANG.THOMAS.

TSAI, YEANG-SHENG. TSAI, JASON.YEANG-SHENG.TSYRUK, ALIAKSEI. TSYRUK, ALEX.TSYRUK, NADZEYA. TSYRUK, NADIA.TSYRUK, VOLHA. TSYRUK, OLGA.URQUILLA ESCOBAR, TANYA.ALEJANDRA. MILNE, TANYA.ALEJANDRA.UWAMAHORO, INNOCENTE. UWAMAHORO, TAMIA.I.VAN ELSWYK, JUSTIN.DAVID. VAN ELSWYK, VINNY.DAVID.VERMETTE, LOUIS.RENE.BRIAN. VERMETTE, RENE.LOUIS.VOISIN, DONA.MARIE. GILLISSIE, DONNA.MARIE.WANG, ANNIE. WANG, KIMBERLY.WELLER, JADE.LEANOR.JILL. SMITH, JADE.LEANOR.JILL.WU, DI. WU, LINDA.DI.YGLESIAS GARCIA, MARIBEL. CASANOVA, MARIBEL.YOUSSEF, SALY.GEORGE.RAMSIS.

YOUSSEF, SALLY.GEORGE.RAMSIS.

YUEN, HOK.YIU. YUEN, LOK.YIU.ZHI, TIAN.ZE. ZHI, PETER.TIANZE.

Sandra leonettiDeputy Registrar General

(144-G627) Registraire générale adjointe de l’état civil

Applications to Provincial Parliament — Private Bills

Demandes au Parlement provincial — Projets de loi d’intérêt privé

PUBLIC NOTICE

The rules of procedure and the fees and costs related to applications for Private Bills are set out in the Standing Orders of the Legislative Assembly's Internet site at http://www.ontla.on.ca or from:

Committees BranchRoom 1405, Whitney Block, Queen's ParkToronto, Ontario M7A 1A2Telephone: 416/325-3500 (Collect calls will be accepted)

Applicants should note that consideration of applications for Private Bills thatarereceivedafterthefirstdayofSeptemberinanycalendaryearmaybepostponeduntilthefirstregularSessioninthenextfollowingcalendaryear.

deBoraH deller,(8699) T.F.N. Clerk of the Legislative Assembly.

Page 19: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4405

Corporation Notices Avis relatifs aux compagnies

THE PROVENANCE LIFE INSURANCE COMPANY

NOTICE OF APPLICATION

Notice is hereby given, pursuant to Section 49 of the Insurance Act (Ontario), that THE PROVENANCE LIFE INSURANCE COMPANY is applying to the Superintendent/ CEO of the Financial Services Commission of Ontario for a licence to carry on the business of life, accident and sickness insurance in Ontario.

The company will carry on business under the name of The Provenance Life Insurance Company, in English, and Provenance, compagnie d’assurance-vie, in French, and its principal office will be located inBurlington, Ontario.

Burlington, December 14, 2011

(144-P470) 52, 53, 1, 2

NOTICE OF INTENTION TO DISSOLVE

TAKE NOTICE that BROCKVILLE CO-OPERATIVE ASSOCIATION intends to file Articles of Dissolution pursuant to the Co-OperativeCorporations Act, R.S.O., 1990 Section 164.

Dated at Prescott, Ontario, this 14th day of December, 2011

SecretaryJoHn aSHByc/o Kenneth J. Durand Professional CorporationP.O. Box 969

(144-P471) Prescott, ON K0E 1T0

Sheriff’s Sale of Lands Ventes de terrains par le shérif

UNDER AND BY VIRTUE OF A WRIT OF SEIZURE AND SALE issued out of the Superior Court of Justice, 70 Wellington St., Brantford, Ontario, N3T 2L9, dated June 10, 1998, File Number 45/98, to me directed, against the real and personal property of, JOSEPH ANGOTTI, FILOMENA ANGOTTI also known as PHYLLIS ANGOTTI, Defendants, at the suit of Clarica Trust Company (formerly The Mutual Trust Company), Plaintiff, I have seized and taken in execution all right, title, interest and equity of redemption of, JOSEPH ANGOTTI, FILOMENA ANGOTTI also known as PHYLLIS ANGOTTI, in and to:

Part of Township Lot 24 Stamford being Part 1 on Reference Plan 59R10864, City of Niagara Falls, Regional Municipality of Niagara, Municipally known as 2715 Portage Road, Niagara Falls, Ontario L2J 2J4

ALL OF WHICH said right, title, interest and equity of redemption of, JOSEPH ANGOTTI, FILOMENA ANGOTTI also known as PHYLLIS ANGOTTI, Defendants, I shall offer for sale by Public Auction in my office at WELLAND COURTHOUSE, 102 East MainStreet, WELLAND, ONTARIO L3B 3W6, on January 25, 2012 at 1:45pm in the conference room on the third floor.

CONDITIONS:The purchaser to assume responsibility for all mortgages, charges, liens, outstanding taxes and other encumbrances. No representation is made regarding the title of the land or any other matter relating to the interest to be sold. Responsibility for ascertaining these matters rests with the potential purchaser(s).

TERMS: Deposit 10% of bid price or $ 1,000.00 whichever is greaterPayable at time of sale by successful bidderTo be applied to purchase priceNon-refundableTenbusinessdaysfromdateofsaletoarrangefinancingandpay balance in full atSHERIFF/ENFORCEMENT OFFICE at102 East Main Street,Welland , Ontario L3B 3W6, 1st floorAllpaymentsincashorbycertifiedchequemadepayabletoMINISTER OF FINANCEDeed Poll provided by Sheriff only upon satisfactory payment in full of purchase price.Other conditions as announced.

THIS SALE IS SUBJECT TO CANCELLATION UP TO TIME OF SALE WITHOUT FURTHER NOTICE.

NO EMPLOYEE OF THE MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL MAY PURCHASE ANY GOODS OR CHATTELS, LANDS OR TENEMENTS EXPOSED FOR SALE BY A SHERIFF UNDER LEGAL PROCESS, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY,

Dated: November 29, 2011

SuSan SecordSheriff’sOffice59 Church St.,St. Catharines, On L2R 7N8

(144-P472) 905-988-6200

Sale of Land for Tax Arrears By Public Tender

Ventes de terrains par appel d'offres pour arriéré d'impôt

MUNICIPAL ACT, 2001

SALE OF LAND BY PUBLIC TENDER

THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS

TAKE NOTICE that tenders are invited for the purchase of the land(s) described below and will be received until 3:00 p.m. local time on Friday January 20, 2012, at the Municipal Office, Finance Department. Thetenders will then be opened in public on the same day at 3:15 p.m. in the Council Chambers.

Description of Lands:

10-05 The Surface Rights only of Lot 4, Plan M330C, T/W BLK A Plan M330C as in C202515, in the Township of Robb, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 4-1 M330C, Pin 65356-0009 Improved – 13 Martineau Ave

Minimum Tender Amount: $13,061.44

10-07 The Surface Rights only of Lot 351, Plan M20S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 7658 Whitney and Tisdale, Pin 65396-0061Vacant Land – Warner Street

Minimum Tender Amount: $ 2,493.72

Description of Lands: 10-09 The Surface Rights only of Lot 50, Plan M25C, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 4384 Whitney and Tisdale, Pin 65397-0595 Improved – 75 Powell Ave

Minimum Tender Amount: $11,991.69

Page 20: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4406 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

10-10 The Surface Rights only of Lot 67, Plan M39S, excepting Part 1, 6R3315, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 1320 Whitney and Tisdale, Pin 65407-0293 Improved – 74 Father Costello Dr

Minimum Tender Amount: $12,215.18

10-12 The Surface Rights only of Lots 295 and 296, Plan M19T, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 4451 Whitney and Tisdale, Pin 65407-0079 Vacant Land – 84 Fourth Ave

Minimum Tender Amount: $14,710.73

10-13 The Surface Rights only of Part Block J, Plan M30T, T/W C261934, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 3184 Whitney and Tisdale, Pin 65407-0382 Improved – 12 Grant Street

Minimum Tender Amount: $15,721.18

10-15 The Surface Rights only of part of Block F, Plan M30T, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 2379 Whitney and Tisdale, Pin 65407-0483.Improved – 35 Dwyer Ave

Minimum Tender Amount: $47,280.76

10-18 The Surface Rights only of Lot 109, Plan M21S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11071 Whitney and Tisdale, Pin 65392-0119.Vacant Land – Haileybury Cres

Minimum Tender Amount: $3,197.98

10-19 The Surface Rights only of Lot 108, Plan M21S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11072 Whitney and Tisdale, Pin 65392-0120.Vacant Land – Haileybury Cres

Minimum Tender Amount: $3,197.98

10-20 The Surface Rights only of Lot 140, Plan M21S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11789 Whitney and Tisdale, Pin 65392-0228.Vacant Land – Emilie St

Minimum Tender Amount: $1,651.80

10-21 The Surface Rights only of Lot 138, Plan M21S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11789 Whitney and Tisdale, Pin 65392-0227.Vacant Land – Emilie St

Minimum Tender Amount: $1,651.80

10-22 The Surface Rights only of Lot 136, Plan M21S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11616 Whitney and Tisdale, Pin 65392-0223.Vacant Land – Emilie St

Minimum Tender Amount: $1,651.80

10-24 The Surface Rights only of Lots 9 and 10, excepting the North 1/2, Plan M12S, in the City of Timmins, District of Cochrane. Pin 65387-0368.Vacant Land – 5888 King St

Minimum Tender Amount: $30,547.73

10-26 Part of Broken Lot 8, Concession 3, being Mining Claim P.20032 as in CP4014 except MRO C304009, in the Township of Cody, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 8370 South East Cochrane, Pin 65385-0066.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $2,889.37

10-27 Mining Claim P.27266, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9221 South East Cochrane, Pin 65384-0028.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,816.79

10-28 Mining Claim P.27267, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9222 South East Cochrane, Pin 65384-0027.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,802.99

10-29 Mining Claim P.27268, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9223 South East Cochrane, Pin 65384-0026.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,779.10

10-30 Mining Claim P.27269, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9224 South East Cochrane, Pin 65384-0025.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,826.93

10-31 Mining Claim P.27265, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9220 South East Cochrane, Pin 65384-0021.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,816.79

10-32 Mining Claim P.27262, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9217 South East Cochrane, Pin 65384-0022.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,813.02

Description of Lands: 10-33 Mining Claim P.27259, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9214 South East Cochrane, Pin 65384-0019.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,799.21

10-34 Mining Claim P.27263, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9218 South East Cochrane, Pin 65384-0023.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,826.93

10-35 Mining Claim P.27264, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9219 South East Cochrane, Pin 65384-0024.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,826.93

10-36 Mining Claim P.27260, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9215 South East Cochrane, Pin 65384-0018.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,826.93

10-37 Mining Claim P.27261, except MRO as in C201665, in the Township of Macklem, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 9216 South East Cochrane, Pin 65384-0017.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,864.58

Page 21: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4407

10-38 The Surface Rights only of the North 1/2 of Lot 6, Concession 6, in the Township of Matheson, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 11480 South East Cochrane, Pin 65361-0006.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $4,591.34

10-42 The Surface Rights only of the North East 1/4 of the South 1/2 of Lot 9, Concession 3, in the Township of Gowan, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 16282 South East Cochrane, Pin 65349-0080.Vacant Land – Not Assigned

Minimum Tender Amount: $1,876.90

10-45 The Surface Rights only of Part of a lane, Plan M52T, closed by C315847, Parts 1 & 8, 6R4346, Lot 16 Plan M52T, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcels 12738 & 2381 Whitney and Tisdale, Pins 65403-0679 & 65403-0680.Vacant Land – 180 Spruce St N

Minimum Tender Amount: $15,076.94

10-46 The Surface Rights only of Lot 74, Plan M74T, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 6261 Whitney and Tisdale, Pin 65403-0467.Improved – 261 Birch St N

Minimum Tender Amount: $12,779.80

10-49 The Surface Rights Only of Lot 7, Lot 8 except Part 1 6R4003, Part of Lot 8 being Part 1 6R4003, Lots 9 to 16 on Plan M2T, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcels 2269, 2241, 12529, 4822, 2558, 3031, 1342, 806, & 1349 Whitney and Tisdale, Pins 65404-1755, 65404-1756, 65404-1757, 65404-1758, 65404-1759, 65404-1760, 65404-1761, 65404-1762, & 65404-1763.Improved – 324-360 Spruce St S

Minimum Tender Amount: $141,444.58

10-51 The Surface Rights only of Part of Lot 2, Concession 3, being the South East Part of the South Part as in CP5162, except C63535, Part 1 CR1452 & Part 9 6R6615, S/T C63136, in the Township of Mountjoy, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 10350 South East Cochrane, Pin 65424-0787.Vacant Land – Gillies St

Minimum Tender Amount: $8,274.34

10-54 The Surface Rights only of Lot 9, Plan M43C, in the City of Timmins, District of Cochrane. Parcel 5495 Whitney and Tisdale, Pin 65403-0936.Improved – 373 Hemlock St

Minimum Tender Amount: $13,991.38

Tenders must be submitted in the prescribed form and must be accompanied by a deposit in the form of a money order or of a bank draft or cheque certified by a bank or trust corporation payable to themunicipality andrepresenting at least 20 per cent of the tender amount.

Except as follows, the municipality makes no representation regard-ing the title to or any other matters relating to the land to be sold. Responsibility for ascertaining these matters rests with the potential purchasers.

This sale is governed by the Municipal Act, 2001 and the Municipal Tax Sales Rules made under that Act. The successful purchaser will be required to pay the amount tendered plus accumulated taxes and the relevant land transfer tax.

The municipality has no obligation to provide vacant possession to the successful purchaser.

For further information regarding this sale and a copy of the prescribed form of tender contact:

Jean FeretyckiChief Tax Collector

kim BazinetDeputy Tax Collector

SuSanne mavor Deputy Tax Collector

The Corporation of the City of Timmins705-360-2633220 Algonquin Blvd East

(144-P473) Timmins, Ontario P4N 1B3

Municipal Act, 2001

SALE OF LAND BY PUBLIC TENDER

THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF STIRLING-RAWDON

TAKE NOTICE that tenders are invited for the purchase of the lands(s) described below and will be received until 3:00 p.m. local time January 26, 2012 at 14 Demorest Road, Stirling, Ontario K0K 3E0.

The tenders will then be opened in public on the same day at the Municipal Offices,14DemorestRoad,Stirling,OntarioK0K3E0.

Description of Land(s):

PCL PLAN-1 SEC 21M83; BLK 45 PL 21M83 SIDNEY;STIRLING-RAWDON; COUNTY OF HASTINGS PIN 40333-0057(LT)Vacant Land along Weaver StreetAssessment Roll No. 12 20 218 010 25401 0000

Minimum Tender Amount: $ 1,607.34

Tenders must be submitted in the prescribed form and must be accompanied by a deposit in the form of a money order or of a bank draft or cheque certifiedbyabankortrustcorporationpayabletoTheCorporationoftheTownship of Stirling-Rawdon and representing at least 20 per cent (20%) of the tender amount.

Except as follows, the municipality makes no representation regard-ing the title to or any other matters relating to the land to be sold. Responsibility for ascertaining these matters rests with the potential purchasers.

The land(s) does(do) not include the mobile homes situate on the land(s), if any.

This sale is governed by the Municipal Act, 2001 and the Municipal Tax Sales Rules made under that Act. The successful purchaser will be required to pay the amount tendered plus accumulated taxes and the relevant land transfer tax and H.S.T., if applicable.

The municipality has no obligation to provide vacant possession to the successful purchaser.

For further information regarding this sale and a copy of the prescribed form of tender contact:

roxanne HearnS, AMCT, TreasurerThe Corporation of the Township of Stirling-Rawdon14 Demorest Road, P.O. Box 40

(144-P474) Stirling, Ontario K0K 3E0

Page 22: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance
Page 23: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4409

Publications under Part III (Regulations) of the Legislation Act, 2006 Règlements publiés en application de la partie III (Règlements)

de la Loi de 2006 sur la législation

THE ONTARIO GAZETTE / LA GAZETTE DE L’ONTARIO

Publications under Part III (Regulations) of the Legislation Act, 2006Règlements publiés en application de la partie III (Règlements)

de la Loi de 2006 sur la législation2011—12—24

ONTARIO REGULATION 462/11 made under the

PROVINCIAL OFFENCES ACT

Made: November 28, 2011 Filed: December 9, 2011

Published on e-Laws: December 12, 2011 Printed in The Ontario Gazette: December 24, 2011

Amending O. Reg. 108/11 (Forms)

Note: Ontario Regulation 108/11 has not previously been amended.

1. Section 1 of Ontario Regulation 108/11 is amended by adding the following subsections: (2) A form issued pursuant to Part II of the Act (Commencement of Proceedings for Parking Infractions) may be provided in either English or French or in both languages, whether or not the form shown on www.ontariocourtforms.on.ca is in both languages. (3) Despite the revocation of Forms 1 to 7 of Regulation 949 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (Parking Infractions), those Forms may continue to be used, in addition to the Forms referred to in this Regulation, until the day that isone year after the day this section comes into force. (4) Despite the revocation of Forms 1, 2, 3, 5 and 6 of Regulation 950 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 (Proceedings Commenced by Certificate of Offence), those Forms may continue to be used, in addition to the Forms referred to in this Regulation, until the day that is six months after the day this section comes into force. 2. Section 8 of the Regulation is revoked and the following substituted: Notice of fine and due date

8. A notice of fine and due date under Part I of the Act shall be in Form 10. 3. Section 15 of the Regulation is revoked and the following substituted: Notice of fine and due date

15. A notice of fine and due date under Part II of the Act shall be in Form 10. 4. Subsections 16 (8) and (9) of the Regulation are revoked. 5. Subsection 17 (4) of the Regulation is amended by striking out “Subsections 16 (1), (2), (3), (4), (8) and (9)” in the portion before clause (a) and substituting “Subsections 16 (1), (2), (3) and (4)”. 6. (1) The Table of Forms to the Regulation is amended by striking out,

1 Certificate of Offence / Procès-verbal d’infraction March 17, 2011 2 Red Light Camera System Certificate of Offence / Procès-verbal d’infraction — système

photographique relié aux feux rouges March 17, 2011

3 Offence Notice / Avis d’infraction March 17, 2011 4 Offence Notice / Avis d’infraction March 17, 2011 5 Red Light Camera System Offence Notice / Avis d’infraction — système photographique relié

aux feux rouges March 17, 2011

6 Red Light Camera System Offence Notice / Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

March 17, 2011

and substituting the following:

2123

Page 24: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4410 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIOTHE ONTARIO GAZETTE / LA GAZETTE DE L’ONTARIO

1 Certificate of Offence / Procès-verbal d’infraction November 2, 2011

2 Red Light Camera System Certificate of Offence / Procès-verbal d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

November 2, 2011

3 Offence Notice / Avis d’infraction November 2, 2011

4 Offence Notice / Avis d’infraction November 2, 2011

5 Red Light Camera System Offence Notice / Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

November 2, 2011

6 Red Light Camera System Offence Notice / Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges

November 2, 2011

(2) The Table of Forms to the Regulation is amended by adding the following:

7.1 Early Resolution Meeting Notice (In Person) / Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne) November 2, 2011

7.2 Early Resolution Meeting Notice (By Electronic Method) / Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique)

November 2, 2011

7.3 Early Resolution Outcome / Entente de règlement rapide November 2, 2011

(3) The Table of Forms to the Regulation is amended by striking out,

9 Notice of Trial / Avis de procès March 17, 2011 10 Notice of Fine and Due Date / Avis d’amende et date d’échéance March 17, 2011

and substituting the following:

9 Notice of Trial / Avis de procès November 2, 2011

10 Notice of Fine and Due Date / Avis d’amende et date d’échéance November 2,2011

(4) The Table of Forms to the Regulation is amended by striking out,

17 Notice of Fine and Due Date / Avis d’amende et date d’échéance March 17, 2011

Commencement

7. (1) Subject to subsections (2) and (3), this Regulation comes into force on the day it is filed. (2) Sections 1 and 2 come into force on the later of the day subsection 7 (4) of Schedule 1 to the Good Government Act, 2011 comes into force and the day this Regulation is filed. (3) Section 3 comes into force on the later of the day subsection 7 (8) of Schedule 1 to the Good Government Act, 2011 comes into force and the day this Regulation is filed.

Made by: Pris par :

Le procureur général,

JOHN PHILIP GERRETSENAttorney General

Date made: November 28, 2011. Pris le : 28 novembre 2011.

52/11

2124

Page 25: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4411THE ONTARIO GAZETTE / LA GAZETTE DE L’ONTARIO

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 462/11 pris en vertu de la

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

pris le 28 novembre 2011 déposé le 9 décembre 2011

publié sur le site Lois-en-ligne le 12 décembre 2011 imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 24 décembre 2011

modifiant le Règl. de l’Ont. 108/11 (Formulaires)

Remarque : Le Règlement de l’Ontario 108/11 n’a pas été modifié antérieurement.

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 108/11 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (2) Un formulaire délivré dans le cadre de la partie II de la Loi (Introduction d’une instance relative à une infraction de stationnement) peut être fourni en français, en anglais, ou dans les deux langues, que le formulaire figurant sur le site www.ontariocourtforms.on.ca soit ou non dans les deux langues. (3) Malgré l’abrogation des formules 1 à 7 du Règlement 949 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Parking Infractions), on peut continuer à utiliser ces formules, en plus des formulaires visés au présent règlement, jusqu’au jour qui tombe un an après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. (4) Malgré l’abrogation des formules 1, 2, 3, 5 et 6 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction), on peut continuer à utiliser ces formules, en plus des formulaires visés au présent règlement, jusqu’au jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2. L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : Avis d’amende et de date d’échéance

8. L’avis d’amende et de date d’échéance prévu à la partie I de la Loi est rédigé selon le formulaire 10. 3. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : Avis d’amende et de date d’échéance

15. L’avis d’amende et de date d’échéance prévu à la partie II de la Loi est rédigé selon le formulaire 10. 4. Les paragraphes 16 (8) et (9) du Règlement sont abrogés. 5. Le paragraphe 17 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Les paragraphes 16 (1), (2), (3), (4), (8) et (9)» par «Les paragraphes 16 (1), (2), (3) et (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a). 6. (1) Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes :

1 Procès-verbal d’infraction / Certificate of Offence 17 mars 2011 2 Procès-verbal d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera

System Certificate of Offence 17 mars 2011

3 Avis d’infraction / Offence Notice 17 mars 2011 4 Avis d’infraction / Offence Notice 17 mars 2011 5 Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera System

Offence Notice 17 mars 2011

6 Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera System Offence Notice

17 mars 2011

par celles-ci :

1 Procès-verbal d’infraction / Certificate of Offence 2 novembre 2011 2 Procès-verbal d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera

System Certificate of Offence 2 novembre 2011

3 Avis d’infraction / Offence Notice 2 novembre 2011 4 Avis d’infraction / Offence Notice 2 novembre 2011 5 Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera System

Offence Notice 2 novembre 2011

6 Avis d’infraction — système photographique relié aux feux rouges / Red Light Camera System Offence Notice

2 novembre 2011

2125

Page 26: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4412 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO THE ONTARIO GAZETTE / LA GAZETTE DE L’ONTARIO

2126

(2) Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes : 7.1 Avis de rencontre pour règlement rapide (en personne) / Early Resolution Meeting Notice (In Person) 2 novembre 2011 7.2 Avis de rencontre pour règlement rapide (par moyen électronique) / Early Resolution Meeting Notice

(By Electronic Method) 2 novembre 2011

7.3 Entente de règlement rapide / Early Resolution Outcome 2 novembre 2011

(3) Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par remplacement des rangées suivantes : 9 Avis de procès / Notice of Trial 17 mars 2011 10 Avis d’amende et date d’échéance / Notice of Fine and Due Date 17 mars 2011

par celles-ci : 9 Avis de procès / Notice of Trial 2 novembre 2011 10 Avis d’amende et date d’échéance / Notice of Fine and Due Date 2 novembre 2011

(4) Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par suppression de la rangée suivante : 17 Avis d’amende et date d’échéance / Notice of Fine and Due Date 17 mars 2011

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt. (2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique et du jour du dépôt du présent règlement. (3) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (8) de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by: Pris par :

Le procureur général,

JOHN PHILIP GERRETSEN Attorney General

Date made: November 28, 2011. Pris le : 28 novembre 2011.

52/11 NOTE: Consolidated regulations and various legislative tables pertaining to regulations can be found on the e-Laws website (www.e-Laws.gov.on.ca). REMARQUE : Les règlements codifiés et diverses tables concernant les règlements se trouvent sur le site Lois-en-ligne (www.lois-en-ligne.gouv.on.ca).

Page 27: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4413

INDEX 52Proclamation ..................................................................................................................................................................................................................................4387Ontario Highway Transport Board .................................................................................................................................................................................................4393Government Notices Respecting Corporations/Avis du gouvernements relatifs aux compagnies ................................................................................................4393Notice of Default in Complying with the Corporations Tax Act/Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés .............................................4393CancellationofCertificateofIncorporation(CorporationsTaxActDefaulters)/Annulationdecertificatdeconstitution(Non-observationdelaLoisur

l’imposition des sociétés) ..........................................................................................................................................................................................................4394CertificateofDissolution/Certificatdedissolution ........................................................................................................................................................................4395Cancellation for Cause (Business Corporations Act)/Annulation à juste titre (Loi sur les sociétés par actions) ..........................................................................4399Erratum Notice/vis d’erreur ...........................................................................................................................................................................................................4399Notice of Default in Complying with the Corporations Information Act/Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ...............................................................................................................................................................................................................4399Marriage Act/Loi sur le mariage ....................................................................................................................................................................................................4399Change Of Name Act/Loi Sur Le Changement De Nom ...............................................................................................................................................................4400Applications to Provincial Parliament — Private Bills/Demandes au Parlement provincial — Projets de loi d’intérêt privé .....................................................4404Corporation Notices/Avis relatifs aux compagnies ........................................................................................................................................................................4405

SHERIFF’S SALE OF LANDS/VENTES DE TERRAINS PAR LE SHÉRIF ............................................................................................................................4405

SALE OF LAND FOR TAX ARREARS BY PUBLIC TENDER/VENTES DE TERRAINS PAR APPEL D'OFFRES POUR ARRIÉRÉ D'IMPôT ..............4405THE CORPORATION OF THE CITY OF TIMMINS .............................................................................................................................................................4405THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF STIRLING-RAWDON ..............................................................................................................................4407

PUBLICATIONS UNDER PART III (REGULATIONS) OF THE LEGISLATION ACT, 2006/RÈGLEMENTS PUBLIÉS EN APPLICATION DE LA PARTIE III (RÈGLEMENTS) DE LA LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION .....................................................................................................................4409

PROVINCIAL OFFENCES ACT O. Reg. 462/11 ...........................................................................................4409

Page 28: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance
Page 29: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance
Page 30: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance
Page 31: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO 4417

Information

La Gazette de l’Ontario paraît chaque samedi, et les annonces à y insérer doivent parvenir à ses bureaux le jeudi à 15h au plus tard, soit au moinsneufjoursavantlaparutiondunumérodanslequelellesfigureront.PourlessemainesincluantlelundidePâques,le11novembreetles congés statutaires, accordez une journée de surplus. Pour connaître l’horaire entre Noël et le Jour de l’An s’il vous plaît communiquez avec le bureau de La Gazette de l’Ontario au (416) 326-5310 ou par courriel à [email protected]

Tarifs publicitaires et soumission de format:

1) Envoyer les annonces dans le format Word.doc par courriel à [email protected]

2) Le tarif publicitaire pour la première insertion envoyée électroniquement est de 75,00$ par espace-colonne jusqu’à un ¼ de page.

3) Pour chaque insertion supplémentaire commandée en même temps que l’insertion initiale, le tarif est 40,00$

4) Lesclientspeuventconfirmerlapublicationd’uneannonceenvisitantlesitewebdeLaGazettedel’Ontario www.ontariogazette.gov.on.ca ou en visionnant une copie imprimée à une bibliothèque locale.

Abonnement:

Le tarif d’abonnement annuel est de 126,50$ + T.V.H. pour 52 ou 53 numéros hebdomadaires débutant le premier samedi du mois de janvier (payable à l’avance) L’inscription d’un nouvel abonnement au courant de l’année sera calculée de façon proportionnelle pour la première année. Un nouvel abonné peut commander des copies d’éditions précédentes de la Gazette au coût d’une copie individuelle si l’inventaire le permet.

Le remboursement pour l’annulation d’abonnement sera calculé de façon proportionnelle à partir de 50% ou moins selon la date. Pour obtenir de l’information sur l’abonnement ou les commandes s.v.p. téléphonez le (416) 326-5306 durant les heures de bureau.

Copies individuelles:

Des copies individuelles de la Gazette peuvent être commandées en direct en ligne au site www.serviceontario.ca/publications ou en téléphonant 1-800-668-9938.

Options de paiement:

Les paiements peuvent être effectués au moyen de la carte Visa, MasterCard ou Amex, ou chèques ou mandats fait à l’ordre du MINISTRE DES FINANCES. Toute correspondance, notamment les changements d’adresse, doit être adressée à :

LA GAZETTE DE L’ONTARIO

393, avenue University, 2e étage, Toronto Ontario M5G 2M2

Téléphone (416) 326-5306

Paiement – Annonces:

Pour le traitement rapide les clients peuvent faire leur paiement au moyen de la carte Visa, MasterCard ou Amex lorsqu’ils soumettrent leurs annonces. Les frais peuvent également être facturés.

MINISTÈRES DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO S.V.P. NOTEZ

Il est possible de payer par carte d’achat du ministère ou par écriture de journal. Les paiements par écriture de journal sont assujettis aux exigences de facturation d’IFIS. S.V.P. communiquez avec le bureau de la Gazette au 416 326-5310 ou à [email protected].

Page 32: Ontario Gazette Volume 144 Issue 52, La Gazette de l ... · 2011 comme le jour où entre en vigueur le paragraphe 2 (3) de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur les services à l'enfance

4418 THE ONTARIO GAZETTE/LA GAZETTE DE L’ONTARIO

Information

The Ontario Gazette is published every Saturday. Advertisements/notices must be received no later than 3 pm on Thursday, 9 days before publication of the issue in which they should appear. For weeks including Easter Monday, November 11th or a statutory holiday allow an extra day. For the Christmas/New Year holiday schedule please contact the Gazette at (416) 326-5310 or by email at [email protected]

Advertising rates and submission formats:

1) Please submit all notices in a Word.doc format to: [email protected]

2) Forafirstinsertionelectronicallysubmittedthebasicrateis$75upto¼page.

3) For subsequent insertions of the same notice ordered at the same time the rate is $40 each.

4) ClientsmayconfirmpublicationofanoticebyvisitingTheOntarioGazettewebsiteat:www.ontariogazette.gov.on.ca or by viewing a printed copy at a local library.

Subscriptions:

Theannualsubscriptionrateis$126.50+H.S.T.for52or53weeklyissuesbeginningthefirstSaturdayinJanuary,payableinadvance.In-yearnewsubscriptionswillbepro-ratedforthefirstyear.AnewsubscribermayorderbackissuesoftheGazetteatthesingle-copyrateas inventory permits.

Refunds for cancelled subscriptions will be pro-rated from 50% or less depending upon date. For subscription information/orders please call (416) 326-5306 during normal business hours.

Single Copies:

Individual Gazette copies may be ordered on-line through the website at www.serviceontario.ca/publications or by phone at 1-800-668-9938.

Payment Options:

Subscriptions may be paid by VISA, AMEX or MasterCard or by Cheque or Money order payable to THE MINISTER OF FINANCE. All subscription enquiries and correspondence, including address changes, should be mailed to:

THE ONTARIO GAZETTE

393 University Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5G 2M2

Telephone: (416) 326-5306

Payment – Notices:

For fastest processing clients may pay by VISA, AMEX or MasterCard when submitting notices. Charges may also be invoiced.

ONTARIO GOVERNMENT MINISTRIES PLEASE NOTE:

Ministry Purchase Card or Journal Entry. Journal payments are subject to IFIS requirements. PleasecontacttheGazetteofficeat416326-5310oratmbs.GazettePubsOnt@ontario.ca.